SUN CP NEWMIDCO LIMITED

SUN CP NEWMIDCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUN CP NEWMIDCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05456337
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DIALGRANGE LIMITED19 mag 200519 mag 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al20 apr 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 apr 2018

    LRESSP

    Cessazione della carica di Zachary Bryan Vaughan come amministratore in data 10 apr 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin O'donnell Mccrain come amministratore in data 10 apr 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Paul Inglett come amministratore in data 04 ago 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Grant Mckinlay il 03 lug 2017

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Grant Mckinlay il 03 lug 2017

    3 pagineCH01

    Nomina di Mr Colin Grant Mckinlay come amministratore in data 03 lug 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 20 apr 2017

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zachary Bryan Vaughan il 28 apr 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Vikram Aneja come amministratore in data 25 nov 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 22 apr 2016

    20 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    18 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2016

    Stato del capitale al 10 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 8

    5 pagineMR05

    Cessazione della carica di Andrew Burych come amministratore in data 22 feb 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83381250004
    MCKINLAY, Colin Grant
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156396250002
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Segretario
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Segretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Segretario
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Segretario
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ANEJA, Vikram
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    EnglandCanadian205778000001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    BURYCH, Andrew
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian199966440001
    CAMILLERI, Donald
    Peel Street
    NG1 4GN Nottingham
    14 Charleston House
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Peel Street
    NG1 4GN Nottingham
    14 Charleston House
    Nottinghamshire
    United KingdomMaltese213942420001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Amministratore
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Amministratore
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81617110003
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Amministratore
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MAWJI-KARIM, Farhad
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    Amministratore
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    United KingdomBritish166000930001
    MCCRAIN, Kevin O'Donnell
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomAmerican195429180002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish138694570001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Amministratore
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Amministratore
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Amministratore delegato nominato
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    ROBINSON, Anthony Martin
    7 Oakfield Road
    AL5 2NF Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Oakfield Road
    AL5 2NF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish55873860004
    SKAAR, Steven Jerry
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish195429190001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Amministratore
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Amministratore
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Amministratore
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    VALERI, Andrea
    57 Cumberland Mansions
    Seymour Place
    W1H 5TF London
    Amministratore
    57 Cumberland Mansions
    Seymour Place
    W1H 5TF London
    EnglandItalian111379810001
    VAUGHAN, Zachary Bryan
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    Level 2
    United Kingdom
    Amministratore
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    Level 2
    United Kingdom
    United KingdomCanadian201919620003
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Amministratore
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    British103272700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SUN CP NEWMIDCO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05456406
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SUN CP NEWMIDCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Borrower deed of charge
    Creato il 28 feb 2012
    Consegnato il 20 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mag 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 03 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security over shares deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor deed
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 28 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 28 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 mag 2006
    Consegnato il 23 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 24 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 24 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SUN CP NEWMIDCO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 apr 2018Inizio della liquidazione
    30 lug 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0