HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED

HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOMES CARING FOR AUTISM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05457634
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza per persone con difficoltà di apprendimento, disturbi mentali e abuso di sostanze (87200) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor, Q4 The Square
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2021

    7 pagineAA

    legacy

    44 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 25 ago 2021

    • Capitale: GBP 1.45450
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 29 feb 2020

    6 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2019

    6 pagineAA

    legacy

    37 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Chi sono gli amministratori di HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FITTON, Garry John
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Segretario
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    243796110001
    FITTON, Garry John
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritishDirector186021130001
    PEARSON, Emma Louise
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    United KingdomBritishCeo259860950001
    SMITH, Shirley Anne
    4 Church Road
    Brean
    TA8 2SF Burnham On Sea
    Somerset
    Segretario
    4 Church Road
    Brean
    TA8 2SF Burnham On Sea
    Somerset
    BritishTeacher105993680001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ARROWSMITH, Aubrey Tobias
    c/o Orbis Partners Llp
    Edmund Street
    B3 2ES Birmingham
    134
    West Midlands
    England
    Amministratore
    c/o Orbis Partners Llp
    Edmund Street
    B3 2ES Birmingham
    134
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant161367380001
    CLARK, Lucy
    30c South Road
    BS23 2HF Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    30c South Road
    BS23 2HF Weston Super Mare
    Avon
    BritishProfessional Director119934300001
    GRENFELL, James Bruce
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    EnglandBritishFinancier141985720001
    KINSEY, Peter
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    United KingdomBritishDirector243796210001
    LACEY, Jan
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    EnglandBritishRecruitment Training Director136282620002
    SMITH, Richard Stanley
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishDirector82070370001
    THOMAS, Paul
    Burnham Road
    TA9 3JF Highbridge
    31
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Burnham Road
    TA9 3JF Highbridge
    31
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director119497690002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Care Management Group Limited
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    United Kingdom
    28 feb 2018
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr Richard Stanley Smith
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    Surrey
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    United Kingdom
    06 apr 2016
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc143950
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04571234
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    HOMES CARING FOR AUTISM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2014
    Consegnato il 17 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    115C hilperton road towbridge wiltshire t/n WT302849.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2014
    Consegnato il 04 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    115D (plot 3 durlston gardens) hilperton road trowbridge wiltshire t/no WT292539.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2014
    Consegnato il 30 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property known as 115D (plot 3 durlston gardens, hilperton road, trowbridge BA14 7JJ registered at land registry under title number WT292539.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Thincats Loan Syndicates Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 feb 2014
    Consegnato il 08 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H property k/a 4 wembdon rise bridgwater somerset. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 mag 2013
    Consegnato il 21 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Starbrook 35A dursley road heywood wiltshire t/no WT289516. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 mag 2013
    Consegnato il 11 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    18 stanway close & 190 greenway road, taunton, somerset t/no:ST279205. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 2013
    Consegnato il 09 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 115B hilperton road trowbridge t/no WT288106 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thincats Loan Syndicates Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 2013
    Consegnato il 11 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 1 durlston gardens 115B hilperton road trowbridge t/n WT288106 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2011
    Consegnato il 25 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thincats Loan Syndicates Limited
    Transazioni
    • 25 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 12 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cj Nominees Limited
    Transazioni
    • 12 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 13 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stafford lodge 87 berrow road burnham on sea somerset.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 2006
    Consegnato il 07 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hilltop care home 32 trewartha park weston-super-mare. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0