SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED

SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05468022
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    14 Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Tyne And Wear
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 giu 2018

    • Capitale: GBP 501,000
    3 pagineSH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2016

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2016

    Stato del capitale al 09 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2015

    Stato del capitale al 12 giu 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    17 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2014

    Stato del capitale al 01 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O City & Northern Ltd Bankside 6 the Watermark Gateshead NE11 9SY England* in data 01 lug 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Ian
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    Segretario
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    175954980001
    CANNON, Catherine Jane
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish10677590001
    CLARK, Ian
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    ScotlandBritish168569590001
    ROBERTSON, William George
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    Amministratore
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    ScotlandBritish88810130001
    WARD, Elliott Allan
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish94095750001
    BURLEY, Irene
    5 Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    Perthshire
    Segretario
    5 Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    Perthshire
    British100911750004
    MUTCH, Robert Gordon
    Altbeg
    Corsee Road
    AB31 5RT Banchory
    Kincardineshire
    Segretario
    Altbeg
    Corsee Road
    AB31 5RT Banchory
    Kincardineshire
    British282820002
    WILSON, Irene
    Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    5
    Scotland
    Segretario
    Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    5
    Scotland
    158257850001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    COWAN, Andrew David
    c/o C/O City & Northern Ltd
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Bankside 6
    England
    Amministratore
    c/o C/O City & Northern Ltd
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Bankside 6
    England
    Uk/EnglandBritish130905070001
    LYON, Steven
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    Amministratore
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    UkBritish97482510001
    WOODS, Kenneth James
    248 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5LX Glasgow
    Amministratore
    248 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5LX Glasgow
    British88972090002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    60471930010

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr William George Robertson
    Perimeter Road
    IV30 6AE Elgin
    10
    Scotland
    06 apr 2016
    Perimeter Road
    IV30 6AE Elgin
    10
    Scotland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings at site BC2103/5 phase 1 monkton business park hebburn tyne and wear part l/h t/n TY453664. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 23 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property being phase 1 monkton business park south mill lane hebburn tyne and wear t/n TY384504,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 26 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over agreement
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 26 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings being unit bc.2103/5 Phase 2 monkton business park hebburn tyne and wear the right title benefit and interest in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0