DERWENTSIDE HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DERWENTSIDE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Convertita/Chiusa |
| Forma giuridica | Convertita o chiusa |
| Numero di società | 05484129 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
- Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari
Dove si trova DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Greengates House Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley County Durham United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso | 4 pagine | CERTIPS | ||||||||||
Varie Forms b & z convert to i&ps | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Derek Robson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Watts Stelling come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Davies come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Alderson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013 | 61 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 giu 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Clive Robson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jill Te Aho come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Janice Docherty come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 054841290004 | 8 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sebert Leslie Cox Obe come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Phillip Toal come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ann Manley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Errington come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 30 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012 | 55 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 giu 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 16 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Derek William Robson il 13 giu 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Davies il 13 giu 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Errington il 13 giu 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2011 | 53 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 giu 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLINTIRE, Keith Anthony | Segretario | Denehurst Hawthorn SR7 8SH Seaham | British | 113760890001 | ||||||
| ARMSTRONG, Joseph | Amministratore | 44 Commercial Street Cornsay Colliery DH7 9BW Durham | United Kingdom | British | 85611670001 | |||||
| BLACKBURN, Christine Mary | Amministratore | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 162303980001 | |||||
| COX OBE, Sebert Leslie | Amministratore | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 175890300001 | |||||
| HUMPHREY, Richard | Amministratore | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | English | 162303300001 | |||||
| PARKES, Kevin John | Amministratore | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 162303370001 | |||||
| ROBSON, Derek William | Segretario | 16 Burns Close DH9 6TP Stanley County Durham | British | 68718250002 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| ALDERSON, Robert | Amministratore | Birch Crescent Burnopfield NE16 6JJ Newcastle Upon Tyne 100 Tyne And Wear England | England | British | 132515220001 | |||||
| BENSON, Glynis | Amministratore | 47 Dunelm Road Moorside DH8 8HP Consett County Durham | England | British | 92964000001 | |||||
| CHRISTER, Carl | Amministratore | Queens Parade DH9 8YJ Annfield Plain 2 Co Durham | England | British | 139283660001 | |||||
| CLARK, Brenda | Amministratore | 71 Denecrest Medomsley DH8 6PY Consett County Durham | British | 116791700001 | ||||||
| DAVIES, Mark | Amministratore | Ridgewood Villas NE3 1SH Newcastle Upon Tyne 2 United Kingdom | England | British | 116791740002 | |||||
| DOCHERTY, Janice | Amministratore | 10 Surtees Terrace Craghead DH9 6EA Stanley County Durham | England | British | 102477060001 | |||||
| ERRINGTON, Steven | Amministratore | Willow Way Ponteland NE20 9RF Newcastle Upon Tyne 40 England | United Kingdom | British | 135160540002 | |||||
| LLEWELLYN, David | Amministratore | 7 George Street Blackhill DH8 0AE Consett Durham | British | 91264990001 | ||||||
| MANLEY, Ann | Amministratore | 37 Birch Crescent Burnopfield NE16 6JQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 116791780001 | |||||
| MILBURN, Olga | Amministratore | 4 Clarence Terrace Tantobie DH9 9TF Stanley County Durham | British | 116791790001 | ||||||
| PARKER, Ann | Amministratore | 7 Dene View East Stanley DH9 6RB Stanley County Durham | England | British | 116791800001 | |||||
| PROUD, William | Amministratore | 15 The Ridings Catchgate DH9 8EE Stanley County Durham | British | 116791830001 | ||||||
| RAFFERTY, James | Amministratore | 25 Greenwell Park DH7 0NW Lanchester County Durham | British | 116791840001 | ||||||
| REDPATH, Amy | Amministratore | Biddlestone Road Heaton NE6 5SL Newcastle Upon Tyne 63 Tyne & Wear England | England | British | 116791860002 | |||||
| ROBSON, Clive, County Councillor | Amministratore | Constance Street DH8 5DY Consett 23 Durham | England | British | 132314740001 | |||||
| ROBSON, Derek William | Amministratore | Magdalene Court Medomsley DH8 6RF Consett 16 County Durham United Kingdom | England | British | 68718250003 | |||||
| STELLING, Watts, Councillor | Amministratore | 53 Bradley Cottages Leadgate DH8 6JY Consett County Durham | England | British | 112350240001 | |||||
| STOKER, Karen Jane | Amministratore | 10 Fenwick Way DH8 5FD Consett County Durham | England | British | 116791890001 | |||||
| TAYLOR, Denise | Amministratore | 76 North Magdalene Medomsley DH8 6RQ Consett County Durham | England | British | 116791900001 | |||||
| TE AHO, Jill | Amministratore | Acton Dene East Stanley NE16 6JJ Stanley 14 County Durham | England | British | 132754060001 | |||||
| TOAL, Phillip | Amministratore | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 162302270001 | |||||
| WILLIAMSON, Jane | Amministratore | 6 Derby Crescent Moorside DH8 8DZ Consett County Durham | British | 116791910001 | ||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
DERWENTSIDE HOMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 24 apr 2013 Consegnato il 02 mag 2013 | In corso | ||
Breve descrizione Lynwood house durham road lanchester county durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 04 dic 2006 Consegnato il 15 dic 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of the proceeds account and the sinking fund and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 dic 2006 Consegnato il 15 dic 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first floating charge the whole of the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 04 dic 2006 Consegnato il 15 dic 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0