DERWENTSIDE HOMES LIMITED

DERWENTSIDE HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDERWENTSIDE HOMES LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 05484129
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Greengates House Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    County Durham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    4 pagineCERTIPS

    Varie

    Forms b & z convert to i&ps
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 22/07/2013
    RES13

    Cessazione della carica di Derek Robson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Watts Stelling come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Davies come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Alderson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013

    61 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    9 pagineAR01

    Cessazione della carica di Clive Robson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jill Te Aho come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janice Docherty come amministratore

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 054841290004

    8 pagineMR01

    Nomina di Mr Sebert Leslie Cox Obe come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Phillip Toal come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ann Manley come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Errington come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    30 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    55 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    16 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Derek William Robson il 13 giu 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Davies il 13 giu 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Errington il 13 giu 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2011

    53 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    14 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di DERWENTSIDE HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TALLINTIRE, Keith Anthony
    Denehurst
    Hawthorn
    SR7 8SH Seaham
    Segretario
    Denehurst
    Hawthorn
    SR7 8SH Seaham
    British113760890001
    ARMSTRONG, Joseph
    44 Commercial Street
    Cornsay Colliery
    DH7 9BW Durham
    Amministratore
    44 Commercial Street
    Cornsay Colliery
    DH7 9BW Durham
    United KingdomBritish85611670001
    BLACKBURN, Christine Mary
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish162303980001
    COX OBE, Sebert Leslie
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish175890300001
    HUMPHREY, Richard
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandEnglish162303300001
    PARKES, Kevin John
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish162303370001
    ROBSON, Derek William
    16 Burns Close
    DH9 6TP Stanley
    County Durham
    Segretario
    16 Burns Close
    DH9 6TP Stanley
    County Durham
    British68718250002
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    ALDERSON, Robert
    Birch Crescent
    Burnopfield
    NE16 6JJ Newcastle Upon Tyne
    100
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Birch Crescent
    Burnopfield
    NE16 6JJ Newcastle Upon Tyne
    100
    Tyne And Wear
    England
    EnglandBritish132515220001
    BENSON, Glynis
    47 Dunelm Road
    Moorside
    DH8 8HP Consett
    County Durham
    Amministratore
    47 Dunelm Road
    Moorside
    DH8 8HP Consett
    County Durham
    EnglandBritish92964000001
    CHRISTER, Carl
    Queens Parade
    DH9 8YJ Annfield Plain
    2
    Co Durham
    Amministratore
    Queens Parade
    DH9 8YJ Annfield Plain
    2
    Co Durham
    EnglandBritish139283660001
    CLARK, Brenda
    71 Denecrest
    Medomsley
    DH8 6PY Consett
    County Durham
    Amministratore
    71 Denecrest
    Medomsley
    DH8 6PY Consett
    County Durham
    British116791700001
    DAVIES, Mark
    Ridgewood Villas
    NE3 1SH Newcastle Upon Tyne
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Ridgewood Villas
    NE3 1SH Newcastle Upon Tyne
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish116791740002
    DOCHERTY, Janice
    10 Surtees Terrace
    Craghead
    DH9 6EA Stanley
    County Durham
    Amministratore
    10 Surtees Terrace
    Craghead
    DH9 6EA Stanley
    County Durham
    EnglandBritish102477060001
    ERRINGTON, Steven
    Willow Way
    Ponteland
    NE20 9RF Newcastle Upon Tyne
    40
    England
    Amministratore
    Willow Way
    Ponteland
    NE20 9RF Newcastle Upon Tyne
    40
    England
    United KingdomBritish135160540002
    LLEWELLYN, David
    7 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    Durham
    Amministratore
    7 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    Durham
    British91264990001
    MANLEY, Ann
    37 Birch Crescent
    Burnopfield
    NE16 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    37 Birch Crescent
    Burnopfield
    NE16 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish116791780001
    MILBURN, Olga
    4 Clarence Terrace
    Tantobie
    DH9 9TF Stanley
    County Durham
    Amministratore
    4 Clarence Terrace
    Tantobie
    DH9 9TF Stanley
    County Durham
    British116791790001
    PARKER, Ann
    7 Dene View
    East Stanley
    DH9 6RB Stanley
    County Durham
    Amministratore
    7 Dene View
    East Stanley
    DH9 6RB Stanley
    County Durham
    EnglandBritish116791800001
    PROUD, William
    15 The Ridings
    Catchgate
    DH9 8EE Stanley
    County Durham
    Amministratore
    15 The Ridings
    Catchgate
    DH9 8EE Stanley
    County Durham
    British116791830001
    RAFFERTY, James
    25 Greenwell Park
    DH7 0NW Lanchester
    County Durham
    Amministratore
    25 Greenwell Park
    DH7 0NW Lanchester
    County Durham
    British116791840001
    REDPATH, Amy
    Biddlestone Road
    Heaton
    NE6 5SL Newcastle Upon Tyne
    63
    Tyne & Wear
    England
    Amministratore
    Biddlestone Road
    Heaton
    NE6 5SL Newcastle Upon Tyne
    63
    Tyne & Wear
    England
    EnglandBritish116791860002
    ROBSON, Clive, County Councillor
    Constance Street
    DH8 5DY Consett
    23
    Durham
    Amministratore
    Constance Street
    DH8 5DY Consett
    23
    Durham
    EnglandBritish132314740001
    ROBSON, Derek William
    Magdalene Court
    Medomsley
    DH8 6RF Consett
    16
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Magdalene Court
    Medomsley
    DH8 6RF Consett
    16
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish68718250003
    STELLING, Watts, Councillor
    53 Bradley Cottages
    Leadgate
    DH8 6JY Consett
    County Durham
    Amministratore
    53 Bradley Cottages
    Leadgate
    DH8 6JY Consett
    County Durham
    EnglandBritish112350240001
    STOKER, Karen Jane
    10 Fenwick Way
    DH8 5FD Consett
    County Durham
    Amministratore
    10 Fenwick Way
    DH8 5FD Consett
    County Durham
    EnglandBritish116791890001
    TAYLOR, Denise
    76 North Magdalene
    Medomsley
    DH8 6RQ Consett
    County Durham
    Amministratore
    76 North Magdalene
    Medomsley
    DH8 6RQ Consett
    County Durham
    EnglandBritish116791900001
    TE AHO, Jill
    Acton Dene
    East Stanley
    NE16 6JJ Stanley
    14
    County Durham
    Amministratore
    Acton Dene
    East Stanley
    NE16 6JJ Stanley
    14
    County Durham
    EnglandBritish132754060001
    TOAL, Phillip
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Amos Drive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YE Stanley
    Greengates House
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish162302270001
    WILLIAMSON, Jane
    6 Derby Crescent
    Moorside
    DH8 8DZ Consett
    County Durham
    Amministratore
    6 Derby Crescent
    Moorside
    DH8 8DZ Consett
    County Durham
    British116791910001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    DERWENTSIDE HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2013
    Consegnato il 02 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Lynwood house durham road lanchester county durham.
    Persone aventi diritto
    • The County Council of Durham
    Transazioni
    • 02 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Account charge
    Creato il 04 dic 2006
    Consegnato il 15 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of the proceeds account and the sinking fund and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent for Itself and the Lenders (Agent)
    Transazioni
    • 15 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 04 dic 2006
    Consegnato il 15 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge the whole of the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee) as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge
    Creato il 04 dic 2006
    Consegnato il 15 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee) as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0