OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC

OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05487744
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor 2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ECLIPSE VCT 4 PLC22 giu 200522 giu 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form 4.40
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2013

    3 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 Old Bailey London EC4M 7AN United Kingdom in data 08 nov 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 ott 2012

    LRESSP

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Nomina di Patricia Standaloft come segretario in data 31 ago 2012

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Celia Linda Whitten come segretario in data 31 ago 2012

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 lug 2012 al 30 set 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2012

    Stato del capitale al 04 lug 2012

    • Capitale: GBP 2,557,604.7
    SH01

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio redatto al 31 lug 2011

    74 pagineAA

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Chi sono gli amministratori di OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STANDALOFT, Patricia
    Floor
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    4th
    England
    England
    Segretario
    Floor
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    4th
    England
    England
    172069850001
    COOPER, Matthew Jonathan
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    6th Floor
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    6th Floor
    West Yorkshire
    United KingdomAmericanDirector78118020003
    HAMBRO, Alexander Robert, Hon
    Guiting Power
    GL54 5UF Cheltenham
    Barton House
    Gloucestershire
    Amministratore
    Guiting Power
    GL54 5UF Cheltenham
    Barton House
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director42914580007
    MILLS, Robert John Henry
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    6th Floor
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    6th Floor
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector62567910001
    OSMOND, Neil Damian
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    Segretario
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    British96837610001
    OSMOND, Neil Damian
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    Segretario
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    BritishSolicitor96837610001
    WHITTEN, Celia Linda
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    Segretario
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    British10627780001
    WHITTEN, Celia Linda
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    Segretario
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    British10627780001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAKER, Tina Robin Klein
    Flat 60
    One Prince Of Wales Road
    NW5 3LW London
    Amministratore
    Flat 60
    One Prince Of Wales Road
    NW5 3LW London
    EnglandAmericanAttorney106830700001
    MELGAARD, Ronald Gregory
    10 Southwick Place
    W2 2TN London
    Amministratore
    10 Southwick Place
    W2 2TN London
    United KingdomBritishCompany Director56575550006
    OSMOND, Neil Damian
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    Amministratore
    5 Breton House
    Barbican
    EC2Y 8DQ London
    BritishSolicitor96837610001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge on cash deposits
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 01 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit shall be and is hereby charged to the bank by way of first fixed charge (as a continuing security) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deposit agreement to secure third party liabilities
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from promotion space group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re eclipse vct 4 PLC and numbered 00484104 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over account balances
    Creato il 02 apr 2008
    Consegnato il 15 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Set-off or transfer the deposit (or any part of it) in payment of the debt (or any part of it) which is due for payment and has not been paid see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 2008
    Charge on cash deposit
    Creato il 08 set 2007
    Consegnato il 19 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the deposit being the sum of £1,000,000.00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance and Leicester PLC
    Transazioni
    • 19 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of deposit by way of security
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 09 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from npi media group limited (the "overadvance client") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the benefit of the assignors' rights, claims, title and interest in the deposit (the "assigned property"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    OCTOPUS ECLIPSE VCT 4 PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2012Inizio della liquidazione
    23 apr 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah Louise Burge
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    William Duncan
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire
    Keith Allan Marshall
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0