IPSA GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIPSA GROUP PLC
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05496202
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IPSA GROUP PLC?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova IPSA GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Frp Advisory Llp Derby House
    12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di IPSA GROUP PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 mar 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per IPSA GROUP PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 lug 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 lug 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 lug 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per IPSA GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    18 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1a the Granary Bulrushes Business Park Coombe Hill Road East Grinstead RH19 4LZ England a C/O Frp Advisory Llp Derby House 12 Winckley Square Preston PR1 3JJ in data 08 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Ordine del tribunale di liquidazione

    pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    legacy

    2 pagineAC93

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Cessazione della carica di Edward Nicolas Cowdery come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Julian Mark Lloyd Vine come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Mclearon come segretario in data 30 set 2018

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2018 al 30 mar 2018

    1 pagineAA01

    Notifica di Encor Power Plc come persona con controllo significativo il 15 giu 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Robert Jonathan Mclearon come amministratore in data 31 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2018 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Millbank Tower 21-24 Millbank 17 Floor London SW1P 4QP England a Unit 1a the Granary Bulrushes Business Park Coombe Hill Road East Grinstead RH19 4LZ in data 04 giu 2018

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Edward Nicolas Cowdery come amministratore in data 17 gen 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di IPSA GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAKER, Susan Angela
    The White House
    Duncton
    GU28 0JZ Petworth
    West Sussex
    Segretario
    The White House
    Duncton
    GU28 0JZ Petworth
    West Sussex
    British71172570001
    MCLEARON, Robert
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary, Bulrushes Business Park
    England
    Segretario
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary, Bulrushes Business Park
    England
    234214970001
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Segretario nominato
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001
    BRYSON, Neil
    Overdale
    Sychnant Pass Road
    LL32 8RE Conwy
    North Wales
    Amministratore
    Overdale
    Sychnant Pass Road
    LL32 8RE Conwy
    North Wales
    WalesBritish10317250001
    COWDERY, Edward Nicolas
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    Amministratore
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    EnglandBritish169444920001
    COX, Michael Neill
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Amministratore
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish10600400003
    EARL, Peter Richard Stephen
    Priory Street
    SN13 0AR Corsham
    Ivy House / 2
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Priory Street
    SN13 0AR Corsham
    Ivy House / 2
    Wiltshire
    England
    EnglandBritish160193030001
    EARL, Peter Richard Stephen
    2 Priory Street
    SN13 0AR Corsham
    Ivy House
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Priory Street
    SN13 0AR Corsham
    Ivy House
    Wiltshire
    EnglandBritish160193030001
    EYRE, John Michael
    Flat 7 Old Library
    125 Battersea High Street
    SW11 3HY London
    Amministratore
    Flat 7 Old Library
    125 Battersea High Street
    SW11 3HY London
    United KingdomBritish75180750008
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Amministratore
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritish60918490001
    LAKER, Susan Angela
    Duncton
    GU28 0JZ Petworth
    The White House
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Duncton
    GU28 0JZ Petworth
    The White House
    West Sussex
    England
    EnglandBritish71172570001
    LEWIS, Clifford William Adrian, Dr
    11 Meadow Manor
    36 Meadow Lane
    FOREIGN Kloof
    Durban 3610
    South Africa
    Amministratore
    11 Meadow Manor
    36 Meadow Lane
    FOREIGN Kloof
    Durban 3610
    South Africa
    South African103039000001
    LINNELL, Richard John
    Crown Place
    Earl Street
    EC2A 4ES London
    30
    England
    Amministratore
    Crown Place
    Earl Street
    EC2A 4ES London
    30
    England
    South AfricaBritish88078090001
    LLOYD VINE, Julian Mark
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary Bulrushes Business Park, Coomb
    England
    Amministratore
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary Bulrushes Business Park, Coomb
    England
    FranceBritish233896920001
    MCLEARON, Robert Jonathan
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    Amministratore
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    United KingdomBritish179303090001
    METCALF, Philip Casson
    Epping Road
    CM19 5HT Roydon
    Hillcroft
    Essex
    Amministratore
    Epping Road
    CM19 5HT Roydon
    Hillcroft
    Essex
    United KingdomBritish153263680002
    OTTO, Mark Christopher
    Crown Place
    Earl Street
    EC2A 4ES London
    30
    England
    Amministratore
    Crown Place
    Earl Street
    EC2A 4ES London
    30
    England
    South AfricaSouth African184138600001
    SAMPSON, Rizelle
    21 Riverdale Rawda Street
    Craigvan
    Fairways 2055
    South Africa
    Amministratore
    21 Riverdale Rawda Street
    Craigvan
    Fairways 2055
    South Africa
    South African127781100001
    SHAW, Elizabeth
    52 Woodwarde Road
    SE22 8UJ London
    Amministratore
    52 Woodwarde Road
    SE22 8UJ London
    EnglandBritish44415340003
    WEST, James Glynn
    Orchard House The Street
    Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    Amministratore
    Orchard House The Street
    Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    EnglandBritish2136250001
    ACI DIRECTORS LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Amministratore delegato nominato
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027730001
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Amministratore delegato nominato
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IPSA GROUP PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Encor Power Plc
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    15 giu 2017
    Bulrushes Business Park
    Coombe Hill Road
    RH19 4LZ East Grinstead
    Unit 1a The Granary
    England
    No
    Forma giuridicaPlc
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    IPSA GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 ott 2014
    Consegnato il 04 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ethosenergy Italia S.P.A.
    Transazioni
    • 04 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 ott 2014
    Consegnato il 04 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ethosenergy Italia S.P.A.
    Transazioni
    • 04 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 lug 2014
    Consegnato il 26 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Radix Investments UK Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2013
    Consegnato il 19 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rurelec PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2013
    Consegnato il 03 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bluestone Securities LTD
    Transazioni
    • 03 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security over cash agreement
    Creato il 14 nov 2012
    Consegnato il 23 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in each deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security over flow-through account
    Creato il 01 apr 2010
    Consegnato il 14 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The flow-through account and the flow through deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The turbines being four complete fiat avio TG50D5 (701D) gas turbines packages as more particularly described in the spa see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security over shares agreement
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares and the related assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 10 apr 2007
    Consegnato il 16 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest present and future in under and to the contract meaning the sale and purchase agreement with an effective date of 15 march 2007. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creato il 05 apr 2007
    Consegnato il 16 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The turbines meaning four complete fiat avio TG50D5 (701D) gas turbine packages. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security over shares agreement
    Creato il 05 apr 2007
    Consegnato il 16 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio meaning the shares and related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of shares
    Creato il 22 giu 2006
    Consegnato il 27 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the shares and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    IPSA GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ago 2019Data della petizione
    23 ott 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Robert Acland
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Praticante
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    The Official Receiver Or Chatham Maritime
    7th Floor Anchorage House
    47-67 High Street
    ME4 4LE Chatham
    Kent
    Praticante
    7th Floor Anchorage House
    47-67 High Street
    ME4 4LE Chatham
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0