GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05513232 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 05 apr 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di John Richard Allen come amministratore in data 30 set 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 05 apr 2011 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Richard Allen il 06 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Samuel Wilton Lee il 01 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 05 apr 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 30 pagine | MA | ||||||||||
Modifiche allo statuto mediante atto legislativo | 2 pagine | CC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Povall come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Wilks come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Nicholson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Bunbury come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Euan Anstruther Gough Calthorpe come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Martin Brennan Woolhouse come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Lee come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Samuel Wilton Lee come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 05 apr 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLHOUSE, Martin Brennan | Segretario | Howards Meadow Kings Cliffe PE8 6YJ Peterborough 7 Northamptonshire England | 146450850001 | |||||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Amministratore | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 54866930002 | |||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Segretario | Chadwick End Farm Oldwich Lane West Chadwick End B93 0BH Solihull West Midlands | British | 54866930001 | ||||||
| READMAN, Alison Mary | Segretario | 12 Prince Rupert's Way WS13 7ER Lichfield | British | 69382380002 | ||||||
| SMITH, Grace Mclean | Segretario | 3 David House 43 Station Road DA15 7DD Sidcup Kent | British | 7736120003 | ||||||
| ACI SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027740001 | |||||||
| ALLEN, John Richard | Amministratore | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 71282600003 | |||||
| ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir | Amministratore | Elvetham Farm House Home Farm Road RG27 8AN Hook Hampshire | Uk | British | 194595910001 | |||||
| BUNBURY, Michael William, Sir | Amministratore | Flat 3 19 Redcliffe Square SW10 9LA London | England | British | 70449390001 | |||||
| MAHONEY, Patrick Edward | Amministratore | 131 Cornwall Road HA4 6AH Ruislip Manor Middlesex | British | 1622710004 | ||||||
| NICHOLSON, Charles Christian, Sir | Amministratore | Turners Green Farm Elvetham RG27 8BE Hook Hampshire | England | British | 43226700001 | |||||
| PICK, Graham John | Amministratore | Hellier Drive Wombourne WV5 8AH Wolverhampton 3 Staffordshire | England | British | 139309010001 | |||||
| POVALL, David Edward | Amministratore | St. Peters Road Harborne B17 0AU Birmingham 45 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 111052510002 | |||||
| WILKS, William Henry George | Amministratore | 22 Cranmer Court Sloane Avenue SW3 3HN London | United Kingdom | British | 109579700001 | |||||
| ACI DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027730001 |
GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 23 gen 2009 Consegnato il 28 gen 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and | Creato il 17 set 2007 Consegnato il 02 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 04 apr 2006 Consegnato il 20 apr 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and | Creato il 06 gen 2006 Consegnato il 12 gen 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002 | Creato il 29 nov 2005 Consegnato il 13 dic 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0