GREYS EXPORTS LIMITED

GREYS EXPORTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREYS EXPORTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05543511
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREYS EXPORTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GREYS EXPORTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREYS EXPORTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MSN EXPORTS LIMITED23 ago 200523 ago 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREYS EXPORTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per GREYS EXPORTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Michael Edward Luedicke come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 ago 2015

    Stato del capitale al 25 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di GREYS EXPORTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Segretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    DAVIES, Simon
    Flambards
    Arrowsmith Road
    BH21 3BE Canford Magna
    Dorset
    Segretario
    Flambards
    Arrowsmith Road
    BH21 3BE Canford Magna
    Dorset
    British97533930001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    DAVIES, Mike
    Flambards
    Arrowsmith Road, Canford Magna
    BH21 3BE Wimborne
    Amministratore
    Flambards
    Arrowsmith Road, Canford Magna
    BH21 3BE Wimborne
    British95090990001
    DAVIES, Neil
    Flambards
    Arrowsmith Road, Canford Magna
    BH21 3BE Wimborne
    Amministratore
    Flambards
    Arrowsmith Road, Canford Magna
    BH21 3BE Wimborne
    British107172060001
    DAVIES, Simon Michael
    Hightown Hill
    BH24 3HQ Ringwood
    Foulford Farm
    Hampshire
    Amministratore
    Hightown Hill
    BH24 3HQ Ringwood
    Foulford Farm
    Hampshire
    EnglandBritish97533930002
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    HELME, Michael John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish91910030002
    LUEDICKE, Michael Edward
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish172196070001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    PRIDMORE, Peter Ian
    6 Mountbatten Square
    Southsea
    PO4 9XY Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    6 Mountbatten Square
    Southsea
    PO4 9XY Portsmouth
    Hampshire
    British121877680001
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    WILLIAMS, Steven Geoffery
    50 Woodlea Road
    BN13 1BN Worthing
    Sussex
    Amministratore
    50 Woodlea Road
    BN13 1BN Worthing
    Sussex
    British105948690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GREYS EXPORTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    B.D.L. Systems Limited
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    England
    30 giu 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione1017495
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GREYS EXPORTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 set 2010
    Consegnato il 13 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 30 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Noteholders and the Purchasers)
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 nov 2006
    Consegnato il 30 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 30 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 apr 2006
    Consegnato il 20 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 07 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re msn exports limited, business base rate tracker account, account number 80836907. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0