SML (SR) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSML (SR) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05546675
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SML (SR) LIMITED?

    • Attività di produzione di programmi televisivi (59113) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SML (SR) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 First Floor Brook Business Centre
    Cowley Mill Road
    UB8 2FX Uxbridge
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SML (SR) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPLASH MEDIA LIMITED25 ago 200525 ago 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di SML (SR) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SML (SR) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagineLIQ14

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2021

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2020

    27 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2019

    27 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2018

    19 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE a Unit 1 First Floor Brook Business Centre Cowley Mill Road Uxbridge UB8 2FX in data 10 gen 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2017

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2016

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2015

    17 pagine4.68

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed splash media LIMITED\certificate issued on 12/01/15
    3 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 18 dic 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU a St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE in data 09 gen 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 ott 2014

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 ott 2014

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 apr 2014

    18 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    27 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Iffigenia Vardanis come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2012

    Stato del capitale al 03 set 2012

    • Capitale: GBP 140,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di SML (SR) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NICHOLLS, Clare Helen
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    Segretario
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    British113431010001
    CHANDOS, Thomas Orlando, Viscount
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    Amministratore
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    EnglandBritish34942190003
    NICHOLLS, Clare Helen
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    Amministratore
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    EnglandBritish113431010001
    TENENBAUM, Jane Elaine
    17 Spaniards End
    NW3 7JG London
    Amministratore
    17 Spaniards End
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish107872110001
    ROBERTS, Jennifer
    69 Harbord Street
    Fulham
    SW6 6PL London
    Segretario
    69 Harbord Street
    Fulham
    SW6 6PL London
    British100796870001
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    HAMMONDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580008
    GARDNER, Malcolm William
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    Amministratore
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    EnglandBritish101769350001
    LEACH, David Dennis Wilkie
    39 Clavering Avenue
    Barnes
    SW13 8DX London
    Amministratore
    39 Clavering Avenue
    Barnes
    SW13 8DX London
    EnglandBritish111135630001
    REES, William Arwel
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritish3205450001
    SALMON, Peter
    232 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    232 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    British106364220001
    VARDANIS, Iffigenia Lily
    Richmond Cottage
    High Street Hurley
    SL6 5LT Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Richmond Cottage
    High Street Hurley
    SL6 5LT Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish107872010001
    HAMMONDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Amministratore
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    73774730003

    SML (SR) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 01 feb 2012
    Consegnato il 07 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £15,975.00. see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 feb 2012
    Consegnato il 07 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £9,600 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 05 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment and by way of fixed charge to the bank the borrowers right title and interest in and to the programme the rights in respect of the programme subject to the itv licence the sole worldwide exclusive and irrevocable right to distribute reproduce exhibit licence and otherwise exploit and deal in and with the programme all rights of copyright in the original screenplay of the programme all ancillary publishing all rights of the borrower pursuant to any agreement the itv licence and all of the borrower's rights title and benefit to and in the same including without limitation any and all sums of money whatever payable to or on account of the borrower by itv pursuant to the itv licence the distribution agreement the proceeds of any and all policies of insurance now or in the future taken out by the borrower in respect of the programme and or the rights all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account. Floating charge any and all of the borrower's rights whatsoever and wheresoever present and or future in and to the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co
    Transazioni
    • 05 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge
    Creato il 30 lug 2009
    Consegnato il 07 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of assignment and by way of fixed charge to teh bank and borrowers right title and interest see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co
    Transazioni
    • 07 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 lug 2009
    Consegnato il 16 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co
    Transazioni
    • 16 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 03 ott 2008
    Consegnato il 14 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right, title and interest in and to the programme being the programme or series of television programmes called piers morgan on..... And the rights in respect of the programme, all rights of copyright, all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account and floating charge all rights in and to the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 14 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over the television programme entitled 'sandbanks'
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 05 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right title and interest in and to the programme. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 05 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2005
    Consegnato il 09 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Television Corporation PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SML (SR) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2013Inizio dell'amministrazione
    30 ott 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    2
    DataTipo
    05 apr 2023Data prevista di scioglimento
    30 ott 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Liquidatore proposto
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Liquidatore proposto
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0