THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED

THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05554871
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Active House 21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARNCOVE LIMITED06 set 200506 set 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 set 2011

    Stato del capitale al 27 set 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore

    4 pagineAP01
    Note
    DataNota
    27 set 2011Clarification The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario

    4 pagineAP03
    Note
    DataNota
    27 set 2011Clarification The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario in data 18 lug 2011

    3 pagineAP03

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore in data 18 lug 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew William Bucknall come amministratore in data 18 lug 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Norman Mark Field come amministratore in data 18 lug 2011

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Trinity Court Molly Millars Lane Wokingham Berkshire RG41 2PY in data 08 set 2011

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Jonathan Bradley Cleland come amministratore in data 18 lug 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Jon Leatherbarrow come amministratore in data 18 lug 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jog Dhody come amministratore in data 18 lug 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Lawrence Segal come amministratore in data 18 lug 2011

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Eugene Scales come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per David Jon Leatherbarrow il 19 apr 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Jonathan Bradley Cleland come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Eugene Patrick Scales il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Jon Leatherbarrow il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBALD, James
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Segretario
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    British162966820001
    BUCKNALL, Matthew William
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Amministratore
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish162066820001
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Amministratore
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth African161860310001
    MERRICK, Matthew Graham
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Amministratore
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish162110530001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Amministratore
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Amministratore
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritish93677590002
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish113047410001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Amministratore delegato nominato
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    SEGAL, Richard Lawrence
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish138744060001
    TIMMS, Glenn Gordon
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    British54133140004

    THE OXFORD HEALTH & RACQUETS CLUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group debenture
    Creato il 08 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0