WATERFRONT INNS LIMITED

WATERFRONT INNS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATERFRONT INNS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05561945
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WATERFRONT INNS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WATERFRONT INNS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 George Street
    W1U 8NU London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WATERFRONT INNS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DE FACTO 1294 LIMITED13 set 200513 set 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATERFRONT INNS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2020
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2021
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WATERFRONT INNS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mar 2021
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma12 mag 2021
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 mar 2020
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per WATERFRONT INNS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2025

    19 pagineLIQ03
    YDX9N5PU

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2024

    18 pagineLIQ03
    YCZKQMGR

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2023

    19 pagineLIQ03
    YBZY8XMR

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2022

    20 pagineLIQ03
    YAZXRSB6

    Dimissioni di un liquidatore

    4 pagineLIQ06
    YA5CT6AW

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600
    Y9XHMF09

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 gen 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01
    Y9XHMEXT

    Cessazione della carica di Seamus (James) Mcaleer come amministratore in data 22 gen 2021

    1 pagineTM01
    X9WW281N

    Cessazione della carica di Ita Gillis come segretario in data 22 gen 2021

    1 pagineTM02
    X9WW27NL

    Nomina di Mrs Ita Gillis come segretario in data 02 lug 2020

    2 pagineAP03
    X9B8GJKY

    Cessazione della carica di James Stephen Higgins come segretario in data 02 lug 2020

    1 pagineTM02
    X98QPBT0

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    X921OX49

    Scissione delle azioni al 22 nov 2019

    6 pagineSH02
    J8KO3N9N

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08
    J8KO3N9V

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    9 pagineAA
    J8KLLNOI

    Cessazione della carica di Stephen Herbert Surphlis come amministratore in data 12 nov 2019

    1 pagineTM01
    X8I3U895

    Cessazione della carica di Martin Francis Magee come amministratore in data 12 nov 2019

    1 pagineTM01
    X8I3U80Y

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X83EPGQO

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08
    X83EOVBS

    Cessazione di Emelda Catherine O'neill come persona con controllo significativo il 11 apr 2019

    1 paginePSC07
    X83EOTGR

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    10 pagineAA
    J7L5BBSZ

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Herbert Surphlis il 01 nov 2015

    2 pagineCH01
    X74KPCI2

    Dettagli del segretario cambiati per Mr James Stephen Higgins il 20 lug 2017

    1 pagineCH03
    X74KP76X

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X74AM9UH

    Chi sono gli amministratori di WATERFRONT INNS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    O'NEILL, Emelda Catherine
    38 Clonvaddy Road
    Cabragh
    BT70 3AR Dungannon
    Co Tyrone
    Ireland
    Amministratore
    38 Clonvaddy Road
    Cabragh
    BT70 3AR Dungannon
    Co Tyrone
    Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director110462690001
    GILLIS, Ita
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Segretario
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    272980880001
    HIGGINS, James Stephen
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Segretario
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrishCompany Director116620060001
    O'NEILL, Emelda Catherine
    38 Clonvaddy Road
    Cabragh
    BT70 3AR Dungannon
    Co Tyrone
    Ireland
    Segretario
    38 Clonvaddy Road
    Cabragh
    BT70 3AR Dungannon
    Co Tyrone
    Ireland
    Northern IrishCompany Director110462690001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001
    LAVERTY, Eamonn Francis
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director164594500001
    MAGEE, Martin Francis
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Amministratore
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director105879500001
    MCALEER, Seamus (James)
    130 Drum Road
    BT80 9DN Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    130 Drum Road
    BT80 9DN Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director159942180001
    SURPHLIS, Stephen Herbert
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Amministratore
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrelandBritishCompany Director116861100005
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    47670880001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WATERFRONT INNS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Emelda Catherine O'Neill
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    06 apr 2016
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Nazionalità: Northern Irish
    Paese di residenza: Northern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WATERFRONT INNS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    11 apr 2019La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    WATERFRONT INNS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 ago 2015
    Consegnato il 04 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society as Security Agent
    Transazioni
    • 04 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bank account charge
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge or from the company to each finance party
    Brevi particolari
    All interest and rights in or to any money standing to the credit of any controlled account. By way of floating charge all the assets to the extent that such assets are not effectively charged by the fixed charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land being hotel premises kings waterfront liverpool t/no MS570124 assignment the insurance policies, the hedging agreements and all rental and other income fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (except as guarantor for the charging company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. L/h land being hotel premises, kings waterfron, liverpool t/no MS570124 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 01 dic 2009
    Consegnato il 03 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property kings waterfront liverpool T.n MS245246 rental and other income arising from any lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 2009
    Consegnato il 03 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units at kings waterfront liverpool by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2007
    Consegnato il 25 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A building agreement for lease dated 11TH april 2007. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 apr 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A development agreement dated 28TH march 2007 and a guarantee dated 5TH april 2007. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 06 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed security over all the rights,title,benefit and interest of the company whatsoever whether present or future,proprietary,contractual or otherwise arising out of or in,to or under a building agreement for lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 06 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed security over all the rights,title,benefit and interest of the company whatsoever whether present or future,proprietary,contractual or otherwise arising out of or in,to or under a building agreement for lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 06 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    WATERFRONT INNS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 gen 2021Inizio della liquidazione
    26 gen 2021Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geraldine Cahill
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    County Londonderry
    Praticante
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    County Londonderry
    Grainne Quinn
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    Northern Ireland
    Praticante
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    Northern Ireland

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0