LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05586358
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FINDUS GROUP LIMITED28 mag 200928 mag 2009
    FOODVEST LIMITED08 nov 200508 nov 2005
    BROOMCO (3920) LIMITED07 ott 200507 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Seconda presentazione di uno stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 lug 2019

    • Capitale: GBP 24,312.22
    18 pagineRP04SH01

    Nomina di Mr John Philip Madden come amministratore in data 08 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William John Showalter come amministratore in data 11 nov 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ in data 08 nov 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    41 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Conflicts of interest 03/07/2019
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    6 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 lug 2019

    • Capitale: GBP 24,312.22
    11 pagineSH01
    Note
    DataNota
    27 nov 2019Clarification A second filed SH01 was registered on 27/11/2019.

    Soddisfazione dell'onere 055863580006 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd il 02 gen 2017

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    16 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    38 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Karen Jeanette Noakes come amministratore in data 01 feb 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2016 con aggiornamenti

    13 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    16 pagineAA

    Nomina di Karen Jeanette Noakes come amministratore in data 29 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy Nicholas Anthony Faller come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Frank Parker come amministratore in data 31 gen 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Segretario nominato
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2249348
    900013350001
    MADDEN, John Philip
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritish264245380001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Segretario
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    British84487230001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CAMPBELL, Christopher
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    Amministratore
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    American109921890001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Amministratore
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish108529830002
    FITZPATRICK, Seamus Philip
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    Amministratore
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    United KingdomIrish65991000003
    FORBES, Hamish Drummond
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Amministratore
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Danish78882450002
    JOHANSSON, Roger
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Amministratore
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Swedish113571210001
    KARLSSON, Cecilia
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Amministratore
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Swedish113571120001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LITTLE, Malcolm John
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish44199400002
    MILNER, David Richard
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    Amministratore
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    United KingdomBritish150546560001
    NOAKES, Karen Jeanette
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish134379900001
    OLSSON, Jorgen
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Amministratore
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Swedish113571020001
    PARKER, Christopher Frank
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish66681550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    SHOWALTER, William John
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandAmerican178622380001
    SHURE, Randl Louis
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    Amministratore
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    American94192640001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Chi sono le persone con controllo significativo di LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLaw Of England And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06025321
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 nov 2015
    Consegnato il 09 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 09 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 2013
    Consegnato il 25 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch
    Transazioni
    • 25 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale the Security Agent
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0