CONVIVIALITY PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONVIVIALITY PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05592636
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONVIVIALITY PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CONVIVIALITY PLC?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONVIVIALITY PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONVIVIALITY RETAIL PLC09 lug 201309 lug 2013
    CONVIVIALITY RETAIL LTD10 mag 201310 mag 2013
    BARGAIN BOOZE HOLDINGS LIMITED17 feb 200617 feb 2006
    INHOCO 3253 LIMITED14 ott 200514 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONVIVIALITY PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CONVIVIALITY PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    20 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    14 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    14 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    18 pagineAM16

    Nomina di un amministratore

    pagineAM01

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    18 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    40 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Weston Road Crewe Cheshire CW1 6BP a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 27 apr 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    pagineAM01

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Soddisfazione dell'onere 055926360011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 055926360012 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Diana Hunter come amministratore in data 19 mar 2018

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 feb 2018

    • Capitale: GBP 80,068.231
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Mark Terence Aylwin come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 dic 2017

    • Capitale: GBP 80,065.6376
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di CONVIVIALITY PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STONE, Ciaran Joseph
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    236865040001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    EnglandBritish55757700003
    JONES, Ian Martin Woodfine
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    United KingdomBritish198235170001
    MORAN, Mark
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    Amministratore
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish60066000008
    NEWMAN, Martin David
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    EnglandBritish140570290001
    ROBINSON, David Peter
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish217253080001
    WILSON, Stephen Graham
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    United KingdomBritish23638320002
    HODGSON, Peter Earl
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    British76086790002
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    188932610001
    WIRTH, Julie Ann
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    182643920001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    AYLWIN, Mark Terence
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish105140040001
    BURCHELL, Kenton Paul
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish185864470001
    CRABTREE, Mark
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Great BritainBritish121416510005
    DASHPER HUGHES, Matthew Ramsay
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish88755670003
    DOCKERTY, Peter
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish190212950001
    HAYHURST, John Andrew
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish243187770001
    HODGSON, Peter Earl
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish76086790002
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish245151040001
    HUNTER, Diana
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish170154190002
    JONES, Amanda Jane
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish191755770001
    LAING, Jennifer Charlina Ellsworth
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish11815800001
    PEDDER, Roger Anthony
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish3530280001
    RAFFLE, Timothy David
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish59084430001
    STANLEY, Timothy Wayne James
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    UkBritish110455010001
    WEBB, Keith Hamilton
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    WalesBritish128600690001
    WIRTH, Julie Ann
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish114305580002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CONVIVIALITY PLC?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 lug 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    CONVIVIALITY PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 22 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 22 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 21 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2015
    Consegnato il 15 ott 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 ott 2015
    Consegnato il 14 ott 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 14 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2013
    Consegnato il 07 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2013
    Consegnato il 07 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2013
    Consegnato il 08 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 set 2012
    Consegnato il 12 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 12 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 08 set 2009
    Consegnato il 11 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assignor with full title guarantee as a continuing security for the payment or discharge of all secured sums assigned absolutely and agreed to assign absolutely to the security agent all its right title and interest in and to the proceeds of the policies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Key-man policies assignment
    Creato il 31 mar 2006
    Consegnato il 08 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the proceeds of the policies being tim stanley £2,000,000 st james place UK PLC policy no 53C05E93, matthew hughes £1,000,000 st james place UK PLC policy no 53C99N81 and peter hodgson £1,000,000 st james place UK PLC policy no 53C99L82.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as the Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 08 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 25 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks (In Its Capacity as the Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 25 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 23 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other present or future subsidiary of the borrower or of any company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eci Ventures Nominees Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CONVIVIALITY PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 apr 2021Fine dell'amministrazione
    05 apr 2018Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Ian David Green
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0