APIA NOMINEE 2 LIMITED

APIA NOMINEE 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPIA NOMINEE 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05593237
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHELFCO (NO. 3141) LIMITED14 ott 200514 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da No 1 Poultry London EC2R 8EJ a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 04 dic 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 nov 2015

    LRESSP

    Cessazione della carica di Andrew Charles Appleyard come amministratore in data 10 nov 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Edwin Ashcroft come amministratore in data 10 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Rowan Hostler come amministratore in data 09 nov 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 09 nov 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2015

    Stato del capitale al 03 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2014

    Stato del capitale al 27 ott 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert William Game come amministratore in data 10 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert William Game come amministratore in data 10 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Courtenay Thomas Warner come amministratore in data 18 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Keogh come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 14 Cornhill London EC3V 3ND United Kingdom

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 22 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di APIA NOMINEE 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2084205
    1278390004
    HOSTLER, Rowan Tracy
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary201266610001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89567200001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario nominato
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023740001
    APPLEYARD, Andrew Charles
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritishHead Of Specialist Funds (Property)131498200001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritishFund Manager131434980001
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Amministratore
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritishCompany Director101932350001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26086560001
    COPELAND, Anne Marie
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    Amministratore
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    United KingdomBritishFund Manager87679960001
    GAME, Robert William
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritishChartered Secretary117946360001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Amministratore
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritishChartered Accountant32807790002
    HODGSON, Paul Andrew
    37b Forge End
    AL2 3EQ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    37b Forge End
    AL2 3EQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor109512150001
    HUMPHREY, Sian
    139 Crescent Road
    N22 7RU London
    Amministratore
    139 Crescent Road
    N22 7RU London
    BritishFund Manager110151390001
    KEOGH, Mark William
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    EnglandIrishFinance Director62140690001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    The Green
    Saxlingham Nethergate
    NR15 1TH Norwich
    Grove Farmhouse
    United Kingdom
    Amministratore
    The Green
    Saxlingham Nethergate
    NR15 1TH Norwich
    Grove Farmhouse
    United Kingdom
    United KingdomBritishInsurance Company Official62939740001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrishAssistant Fund Manager124787300001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishProperty Investment Director73793650001
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishFund Manager105566370001
    SHAH, Nikunj Nalin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritishChartered Accountant131325870001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor60348780002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritishCompany7356840002
    MIKJON LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Amministratore delegato nominato
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023730001

    APIA NOMINEE 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental charge by way of legal mortgage
    Creato il 21 mag 2010
    Consegnato il 04 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage in properties f/h sovereign house, vision park, chivers way, histon, cambridge. T/n CB170451,. F/h endeavour house, vison park, chivers way, histon, cambridge t/n CB136770. F/h conqueror house, vison park, chivers way, histon, cambridge t/n CB170577, see image for more properties.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rent and all other monies in terms of the leases of the property 95, 97 and 99 haymarket terrace edinburgh t/no MID76691 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 11 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    225-255 bath street glasgow t/n GLA181457 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 11 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 11 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    St magnus house, guild street, aberdeen t/n ABN56755 and subjects under t/n ABN91199 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 11 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rent and all other monies in the terms of the property being 225 to 255 bath street glasgow t/no GLA181457 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rent and all other monies in the terms of the property being st magnus house, guild street, aberdeen t/n ABN56755 and the subjects under t/n ABN91199 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rent and all other monies in the terms of the property being new telecom house, 73-77 college street, aberdeen and the westernmost part of level 4 of the multi-storey car park at college street, aberdeen t/n ABN83425 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 17 dic 2009
    Consegnato il 11 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    New telecom house, 73-77 college street, aberdeen and the watermost part of level 4 of the multi storey car park at college street, aberdeen t/n ABN83425 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 11 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 17 dic 2009
    Consegnato il 11 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    95, 97 and 99 haymarket terrace, edinburgh t/n MID76691 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 11 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2009
    Consegnato il 31 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation dated 29TH march 2007 and creation
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole entitlement to receive for the time being and from time to time all sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 30/03/07 and
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St magnus house guild street aberdeen and access lane pertaining thereto.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 22 gen 2007
    Consegnato il 26 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by each charger or the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a new castle house castle boulevard nottingham t/no NT82718 booke debts bank account plant and machinery all rental income all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation dated 29 september 2006, creation
    Creato il 10 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole entitlement to receive for the time being and from time to time all sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation dated 29 september 2006, creation
    Creato il 10 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole entitlement to receive for the time being and from time to time all sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental mortgage deed supplemental to a debenture (the fixed and floating securtiy dated 21 december 2005)
    Creato il 30 set 2006
    Consegnato il 06 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor or the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 22 to 40 (even) and surrey house eden street 2 to 6 (even) brook street 1, 1A and 3 st jame's road kingston t/n SGL662717 l/h cheltenham house eden street kingston upon thames t/n SGL662719 * for details of further property charged please refer to form 395 *. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 october 2006 and
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a the apex 95 to 99 haymarket terrace edinburgh t/no MID76691.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 october 2006 and
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a 225 to 255 (odd numbers) bath street glasgow t/no GLA181457.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 16 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums payable in terms of the leases in name of rent, including all interest or payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 16 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 16 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums payable in terms of the lease in name of rent, including all interest or payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 16 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 23 december 2005 and
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 09 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole that plot of or area of ground lying on or towards the north east of college street and south east of guild street aberdeen k/a 73-77 college street aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees
    Transazioni
    • 09 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 23 december 2005 and
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 09 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming lomond house 9 george street glasgow and comprising all and whole that steading of ground containing 1,105 square yards and eight square feet of thereby imperial measure lying on the south side of george square and on the west of hanover street glasgow within the parish (formerly barony parish) of glasgow and county of lanark. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC and Its Successors and Assignees Whomsoever
    Transazioni
    • 09 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 04 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property book debts bank accounts rights under any contract or any agreement the benefit of all guarantees warranties and representations all its rental income and all proceeds in respect of insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    APIA NOMINEE 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 nov 2015Inizio della liquidazione
    15 giu 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0