TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED

TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05593395
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor, St James House The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GENER8 FINANCE LIMITED14 ott 200514 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 22 mag 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 18/05/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 mag 2022

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr James Matthew Arthur Roberts come segretario in data 14 apr 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jennifer Bodey come segretario in data 14 apr 2022

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mag 2021

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gener8 Finance Holdings Limited come persona con controllo significativo il 07 dic 2020

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Richard Ian Smith come amministratore in data 27 feb 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Edward John Rimmer come amministratore in data 22 feb 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mag 2020

    27 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 26 nov 2020

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Edward John Rimmer come amministratore in data 30 apr 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mag 2019

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 055933950003, creata il 16 apr 2019

    6 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBERTS, James Matthew Arthur
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Segretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    295102770001
    RIMMER, Edward John
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Amministratore
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    United KingdomBritish67922850004
    ROBERTS, James Matthew Arthur
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Amministratore
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    EnglandBritish230810310001
    BODEY, Jennifer
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Segretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    247026940001
    CASE, Thomas Richard
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Segretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    233229490001
    RAVEN, Philip
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Segretario
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    197613660001
    RICHARDS, Tracey Louise
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Segretario
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    British102918940002
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Segretario
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    39259480001
    BUCKLEY, Peter Jonathan
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritish142502720001
    COX, Michael Francis
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    Langwood House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    Langwood House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish54129020003
    INGOLDBY, Jillian
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish126822990001
    LONGHURST, Jeffrey Daniels
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish119069920001
    MATON, Timothy
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish72223280001
    OGILVY, Diarmid
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British131878810001
    RICHARDS, David Mark
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritish126107150001
    RICHARDS, Tracey Louise
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritish102918940002
    RIMMER, Edward John
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Amministratore
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    United KingdomBritish67922850004
    SCOTT, Simon Gregory Thomas
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish58936390002
    SMITH, Richard Ian
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Amministratore
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    WalesBritish105152600001
    STOKES, Paul Andrew
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish161361360003
    SUMNER, Brian Richard
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British59440390001
    WATERS, Jonathan Richard
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish114098810001
    WIGNALL, Mark Steven
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish18462760001
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Amministratore
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    39259470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Time Commercial Finance Limited
    St James House, The Square
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor
    England
    06 apr 2016
    St James House, The Square
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione09393231
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2019
    Consegnato il 25 apr 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 mar 2019
    Consegnato il 08 mar 2019
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 08 mar 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    All assets debenture
    Creato il 01 mag 2008
    Consegnato il 10 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0