EPIC (WIDNES) LIMITED

EPIC (WIDNES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEPIC (WIDNES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05603111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EPIC (WIDNES) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Level 13, Broadgate Tower
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STADIUM (WIDNES) LIMITED15 nov 200515 nov 2005
    INHOCO 3257 LIMITED25 ott 200525 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2019

    5 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 mar 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Daniel O'neill come amministratore in data 26 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2017 al 30 giu 2018

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2018 al 30 set 2018

    1 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    Increase authorised capital from £1000 to £2000 07/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Mr Daniel O'neill come amministratore in data 08 dic 2017

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 056031110018, creata il 08 dic 2017

    45 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name11 dic 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 dic 2017

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da Welton Grange Welton Brough East Yorkshire HU15 1NB a Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2EW in data 11 dic 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Calum Scott Bruce come amministratore in data 08 dic 2017

    2 pagineAP01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 dic 2017

    • Capitale: GBP 2,000,000
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Amanda Jayne Standish come amministratore in data 08 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Dyson Healey come amministratore in data 08 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edwin Dyson Healey come amministratore in data 08 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexander Martin Clare come amministratore in data 08 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Stuart Fish come amministratore in data 08 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Stuart Fish come segretario in data 08 dic 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Rankin Vallance Laing come amministratore in data 08 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione di Stadium (Newport) Ltd come persona con controllo significativo il 08 dic 2017

    1 paginePSC07

    Chi sono gli amministratori di EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRUCE, Calum Scott
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    ScotlandScottish198600380001
    LAING, Rankin Vallance
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    ScotlandBritish185571350001
    CROOKS, Michael Clive
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road, Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road, Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    British48504730008
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Segretario
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    172292060001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLARE, Alexander Martin
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish184073370001
    CROOKS, Michael Clive
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish48504730009
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish99181180003
    HEALEY, Edwin Dyson
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish1798990001
    HEALEY, Paul Dyson
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish7349500004
    O'NEILL, Daniel
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    United KingdomBritish211889980001
    STANDISH, Amanda Jayne
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish172278520001
    SWALES, Paul Nigel
    3 Orchard Close
    WF8 3NL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Orchard Close
    WF8 3NL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish42213720002
    WILLOX, Shaun
    10 Bull Pasture
    South Cave
    HU15 2HT Brough
    North Humberside
    Amministratore
    10 Bull Pasture
    South Cave
    HU15 2HT Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish99708360002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 Broadgate Tower
    United Kingdom
    08 dic 2017
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 Broadgate Tower
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10978359
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Stadium (Newport) Ltd
    Cowgate
    Welton
    HU15 1NB Brough
    Welton Grange
    England
    06 apr 2016
    Cowgate
    Welton
    HU15 1NB Brough
    Welton Grange
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom Company Law - Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Numero di registrazione03772449
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    EPIC (WIDNES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 dic 2017
    Consegnato il 12 dic 2017
    In corso
    Breve descrizione
    All estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by the company including the freehold and leasehold property known as widnes shopping park, widnes, cheshire, WA8 7NT registered at the land registry under title numbers CH223723, CH398553, CH399521, CH448374, CH574659 and CH623717.. Please see the charge instrument for more details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 mar 2015
    Consegnato il 01 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Widnes shopping park temperley street widnes title no CH398553, CH448374, CH574659, CH3995421, CH623717 and CH223723.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC (Party A)
    Transazioni
    • 01 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 gen 2015
    Consegnato il 16 gen 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold land on the west side of green oaks way widnes title number CH623717.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2013
    Consegnato il 02 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H land at widnes shopping park green oaks way widnes whole t/no CH607150 and part t/nos CH257449 CH602602 and LA356680. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 apr 2012
    Consegnato il 19 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge and assignment
    Creato il 05 mar 2010
    Consegnato il 26 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest present and future to in and arising out of or in respect of the agreements being the agreement to lease in respect of units 9 and 10 widnes shopping park widnes, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 26 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment
    Creato il 05 mar 2010
    Consegnato il 13 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest present and future to in and arising out of or in respect of the agreements being the agreement to lease in respect of unit 5 widnes shopping park widnes, made between the company and poundstretcher limited. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 13 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment
    Creato il 29 ott 2009
    Consegnato il 06 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest present and future to, in and arising out or in respect of, the agreements, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 06 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 17 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest present and future to, in and arising out or in respect of the agreements. Agreements means lease made between stadium (widnes) limited, river island clothing co. Limited. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) the Security Trustee
    Transazioni
    • 17 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of assignment
    Creato il 14 lug 2008
    Consegnato il 19 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 10 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The agreements being the agreement to lease in respect of the property k/a the windmill centre lagsdale road widnes the benefit of the agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2008
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 24 apr 2008
    Consegnato il 25 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unregistered land demised by a lease and deed of variation dated 14 june 2007 made between the council of the borough of halton and the mortgagor land by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 25 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 2008
    Consegnato il 19 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The windmill centre lugsdale road widnes t/nos CH448374, CH398553, CH399521 and CH223723 by way of fixed charge, all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 mar 2008
    Consegnato il 19 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment
    Creato il 13 mar 2008
    Consegnato il 19 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest to in and arising out or in respect of the agreements and all rights titles and benefits monies receivable and interests of the company under them see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 apr 2006
    Consegnato il 27 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment
    Creato il 11 gen 2006
    Consegnato il 13 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right,title and interst present and future to in and arising out or in respect of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h land known as the windmill centre lugsdale road widnes t/n's CH448374 CH38553 CH399521 and f/h land being the former site of a pump house lying to the east of timerley street widnes t/n CH223723,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EPIC (WIDNES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 apr 2020Data di scioglimento
    28 mar 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David F Rutherford
    60 Constitution Street
    Leith
    EH6 6RR Edinburgh
    Praticante
    60 Constitution Street
    Leith
    EH6 6RR Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0