ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED

ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05613278
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    • Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 4130 LIMITED04 nov 200504 nov 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 mag 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 mag 2018

    9 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Varie

    AD03
    2 pagineMISC

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG United Kingdom a C/O Admiral Taverns (Chester) Limited 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ a 1 More London Place London SE1 2AF in data 18 lug 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 mag 2017

    LRESSP

    Dettagli del segretario cambiati per A G Secretarial Limited il 16 giu 2017

    1 pagineCH04

    Soddisfazione dell'onere 056132780010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 056132780008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 056132780009 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    7 pagineRP04CS01

    Bilancio redatto al 28 mag 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    Note
    DataNota
    14 dic 2016Clarification A second filed CS01 (information about people with significant control) was registered on 14/12/2016

    Bilancio redatto al 30 mag 2015

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2014

    Stato del capitale al 18 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 056132780010, creata il 09 ott 2014

    84 pagineMR01

    Cessazione della carica di Jonathan Paveley come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 01 giu 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Memorandum e Statuto

    15 pagineMEM/ARTS

    Chi sono gli amministratori di ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Segretario
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritish119327230001
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish153480970001
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritish123243570001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106840540001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Amministratore
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritish142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Amministratore
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritish54137480002
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish100582600002
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    British53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish2541420006
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05273732
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2014
    Consegnato il 16 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 12 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 12 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 09 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2009
    Consegnato il 07 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 04 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 02 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 feb 2006
    Consegnato il 06 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 feb 2006
    Consegnato il 15 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 15 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ADMIRAL TAVERNS (PH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 mag 2017Inizio della liquidazione
    04 dic 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0