GARWYN GROUP LIMITED

GARWYN GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGARWYN GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05622838
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GARWYN GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GARWYN GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7th Floor 1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GARWYN GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3934) LIMITED15 nov 200515 nov 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di GARWYN GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per GARWYN GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 18 mar 2022

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium account 18/03/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 30 giu 2021

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 056228380012, creata il 01 nov 2021

    63 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 056228380011 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2020

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Davies Group Limited 8 Lloyd's Avenue London EC3N 3EL England a 7th Floor 1 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7AA in data 09 ago 2018

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 056228380011, creata il 27 apr 2017

    50 pagineMR01

    Cessazione della carica di Peter Haran come amministratore in data 28 mar 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 056228380009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 056228380010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 056228380008 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di GARWYN GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEBIASE, Antonio
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    Amministratore
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    United KingdomBritishFinance Director34477220009
    JOHNSON, Lesley Mary
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    Amministratore
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    United KingdomBritishDirector165524400001
    SAULTER, Daniel Mark
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    Amministratore
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    7th Floor
    England
    EnglandBritishChief Executive180589450001
    CHAPMAN, Ian Stuart
    5 Jarvist Place
    Kingsdown
    CT14 8AL Deal
    Kent
    Segretario
    5 Jarvist Place
    Kingsdown
    CT14 8AL Deal
    Kent
    BritishFinance Director111833350001
    FORD, Stephen George
    31 Wellesley Road
    CO3 3HE Colchester
    Essex
    Segretario
    31 Wellesley Road
    CO3 3HE Colchester
    Essex
    BritishCorp Dev Director126209580001
    SAGGU, Ranvir
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    Segretario
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    165548710001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    ABLETT, Timothy Andrew
    Benover House
    Rectory Lane
    CT21 4QA Saltwood
    Kent
    Amministratore
    Benover House
    Rectory Lane
    CT21 4QA Saltwood
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant65924000002
    CHAPMAN, Ian Stuart
    5 Jarvist Place
    Kingsdown
    CT14 8AL Deal
    Kent
    Amministratore
    5 Jarvist Place
    Kingsdown
    CT14 8AL Deal
    Kent
    EnglandBritishFinance Director111833350001
    ELLEN, Simon Tudor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritishInvestor Director111926600001
    FORD, Stephen George
    31 Wellesley Road
    CO3 3HE Colchester
    Essex
    Amministratore
    31 Wellesley Road
    CO3 3HE Colchester
    Essex
    BritishChief Operating Officer126209580001
    HARAN, Peter
    c/o Davies Group Limited
    Lloyd's Avenue
    EC3N 3EL London
    8
    England
    Amministratore
    c/o Davies Group Limited
    Lloyd's Avenue
    EC3N 3EL London
    8
    England
    Republic Of IrelandIrishDirector165641070001
    MCCULLOCH, Stewart William Robert
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    Amministratore
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    EnglandBritishChief Executive Officer137103590001
    NIEMCZEWSKI, Artur Pawel
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    Amministratore
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    EnglandBritishDirector68648470003
    PATTERSON, Nicholas John
    Smythe Road
    CM11 1SE Billericay
    28
    Essex
    Amministratore
    Smythe Road
    CM11 1SE Billericay
    28
    Essex
    United KingdomBritishCommercial Director138566490001
    SAGGU, Ranvir Singh
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    Amministratore
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    EnglandBritishDirector115958310001
    TREANOR, Declan Patrick
    6 Officers Terrace Church Lane
    The Historic Dockyard
    ME4 4LJ Chatham
    Kent
    Amministratore
    6 Officers Terrace Church Lane
    The Historic Dockyard
    ME4 4LJ Chatham
    Kent
    United KingdomIrishManaging Director109549120001
    WOODLEY, Paul Jonathan
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    Amministratore
    8-9 Woodbrook Crescent
    Radford Way
    CM12 0EQ Billericay
    Essex
    EnglandBritishDirector41161540001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Chi sono le persone con controllo significativo di GARWYN GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Davies Group Limited
    Lloyd's Avenue
    EC3N 3EL London
    8
    England
    01 lug 2016
    Lloyd's Avenue
    EC3N 3EL London
    8
    England
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2004
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione6479822
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GARWYN GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 nov 2021
    Consegnato il 05 nov 2021
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 05 nov 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2017
    Consegnato il 09 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Intermediate Capital Group PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 lug 2015
    Consegnato il 04 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H suite 2A, york house, york street, manchester. Trademark garwyn. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 feb 2015
    Consegnato il 23 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property described as suite 2A york house york street manchester.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 dic 2013
    Consegnato il 18 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property being unit 8 shelduck house woodbrook crescent radford way billericay essex, unit 9 shelduck house woodbrook crescent radford way billericay essex and second floor latham house paradise circus birmingham please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 gen 2013
    Consegnato il 01 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 01 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 feb 2011
    Consegnato il 18 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company as principal obligor and not merely as surety to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart Mcculloch & Nicholas Patterson
    Transazioni
    • 18 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman policies
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 19 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ian chapman policy no L0192079672,sum assured £300,000,stephen ford policy no L0195969672 sum assured £300,000,declan treanor policy no L0199769672,sum assured £500,000 and all assured by them and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 19 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £300,000 policy in respect of ian chapman policy no L0192079672DB,£300,000 policy in respect of stephen ford policy no L0195969672DN and a £500,000 policy in respect of declan treanor policy no L0199769672Y together with all sums assured by them and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The shares all other stocks shares debentures bonds warrants coupons negotiable instruments certificates of deposit or other securities or investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Unquoted Investments Limited
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 30 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £368,533 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The shares and all other stocks shares debentures bonds warrants coupons negotiable instruments certificates of deposit or other securities or "investments". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Declan Treanor (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0