PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED

PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05623376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3941) LIMITED15 nov 200515 nov 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 nov 2015

    Stato del capitale al 16 nov 2015

    • Capitale: GBP 328,911.69
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    20 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 056233760010, creata il 11 mar 2015

    19 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 056233760009, creata il 11 mar 2015

    72 pagineMR01

    Nomina di Mr Gareth John Hurfurt come amministratore in data 26 feb 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2014

    Stato del capitale al 18 nov 2014

    • Capitale: GBP 328,911.69
    SH01

    Nomina di Mr Justin Trevor Cooper come amministratore in data 07 mag 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gordon Trevarthen Farmiloe come amministratore in data 07 mag 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2013

    Stato del capitale al 27 nov 2013

    • Capitale: GBP 328,911.69
    SH01

    Cessazione della carica di Richard Price come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Price come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOPER, Justin Trevor
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United StatesBritishDirector184758430001
    HURFURT, Gareth John
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant112699190001
    PRICE, Richard Duncan
    2 Park Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XN Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    2 Park Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XN Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director111545180001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Amministratore
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    EnglandBritishAccountant48633500003
    FARMILOE, Philip Geoffrey
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director23681750002
    JOLLEY, Stephen Peter
    36 Old Canyon Lane
    Ormond Beach
    Florida 32174
    Usa
    Amministratore
    36 Old Canyon Lane
    Ormond Beach
    Florida 32174
    Usa
    EnglandBritishDirector111545250001
    PRICE, Richard Duncan
    2 Park Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XN Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Park Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XN Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director111545180001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    PREMIER BATHROOMS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2015
    Consegnato il 13 mar 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon London Branch as Security Trustee (As Security Trustee for Each of the Secured Parties )
    Transazioni
    • 13 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2015
    Consegnato il 13 mar 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon London Branch as Security Trustee (As Security Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 24 ott 2011
    Consegnato il 28 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 18 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Philip Farmiloe
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other irredeemable loan stock holders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other redeemable loan stock holders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gordon Trevarthen Farmiloe
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0