NAPSTER GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNAPSTER GROUP PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05628362
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NAPSTER GROUP PLC?

    • Attività di società di venture capital e di sviluppo (64303) / Attività finanziarie e assicurative
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NAPSTER GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    The Broadgate Tower Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NAPSTER GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MELODYVR GROUP PLC21 mag 202021 mag 2020
    EVR HOLDINGS PLC13 mag 201613 mag 2016
    ARMSTRONG VENTURES PLC31 lug 201231 lug 2012
    ELM INVESTMENTS PLC19 gen 200619 gen 2006
    ELM INVESTMENTS LIMITED18 nov 200518 nov 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di NAPSTER GROUP PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per NAPSTER GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Anthony Roland Matchett come amministratore in data 28 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Graham Read come amministratore in data 28 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Grant Dollens come amministratore in data 28 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Andrew Cole come amministratore in data 28 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew James Botha come amministratore in data 28 gen 2022

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Poland Street London W1F 7NN England a The Broadgate Tower Third Floor 20 Primrose Street London EC2A 2RS in data 20 lug 2022

    1 pagineAD01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Soddisfazione dell'onere 056283620003 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 056283620002 in pieno

    4 pagineMR04

    Stato del capitale al 01 feb 2022

    • Capitale: GBP 34,800,626.1484
    3 pagineSH19

    Certificato di riduzione del premio azionario

    1 pagineCERT19

    legacy

    1 pagineOC138

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consolidate shares, approve amendments, reduce share premium account,cancel shares,re-register company, 20/12/2021
    RES13

    Cessazione della carica di Lansing Alden Davis come amministratore in data 20 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr William Grant Dollens come amministratore in data 14 apr 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Lansing Alden Davis come amministratore in data 19 lug 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter Graham Read come amministratore in data 19 lug 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 28 dic 2020

    52 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 056283620003, creata il 01 apr 2021

    125 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 056283620001 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di NAPSTER GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANCOCK, Steven Robert
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    United KingdomBritish114064710001
    BROWN, Andy
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    Segretario
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    254283380001
    KOTECHA, Manish Morarji
    Citibase, Imperial House
    St. Nicholas Circle
    LE1 4LF Leicester
    Suite 9
    Leicestershire
    England
    Segretario
    Citibase, Imperial House
    St. Nicholas Circle
    LE1 4LF Leicester
    Suite 9
    Leicestershire
    England
    174967340001
    LAX, Jacob Chaim
    101 Windermere Avenue
    N3 3RB London
    Segretario
    101 Windermere Avenue
    N3 3RB London
    British66506480001
    NICOLSON, Sean
    Camden Wharf
    28 Jamestown Road
    NW1 7BY London
    3rd Floor
    England
    Segretario
    Camden Wharf
    28 Jamestown Road
    NW1 7BY London
    3rd Floor
    England
    199491980001
    THERON, Sebastian
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    Segretario
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    232488740001
    WATT, Karin Frances
    Brunton
    Collingbourne Kingston
    SN8 3SE Marlborough
    Longmead
    Wiltshire
    Great Britain
    Segretario
    Brunton
    Collingbourne Kingston
    SN8 3SE Marlborough
    Longmead
    Wiltshire
    Great Britain
    British84550290001
    INTERNATIONAL REGISTRARS LIMITED
    Finsgate
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9EE London
    Segretario
    Finsgate
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9EE London
    75643100001
    BAZIA, Efraim
    309 Meromit Street
    Mod'In
    Israel
    Amministratore
    309 Meromit Street
    Mod'In
    Israel
    IsraelIsraeli115779720001
    BOTHA, Andrew James
    109 Strawberry Vale
    TW1 4SJ Twickenham
    Clyde House
    England
    Amministratore
    109 Strawberry Vale
    TW1 4SJ Twickenham
    Clyde House
    England
    EnglandBritish255110260001
    COLE, Simon Andrew
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    United KingdomBritish75273740005
    COLEMAN, Malcolm Jerry
    37 Springfield Road
    NW8 8QJ London
    Amministratore
    37 Springfield Road
    NW8 8QJ London
    United KingdomBritish26897650001
    DAVIS, Lansing Alden
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    Amministratore
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    EnglandAmerican286091340001
    DOLLENS, William Grant
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandAmerican286091350001
    EGERTON, Joseph Reginald Salisbury
    Brunton
    Collingbourne Kingston
    SN8 3SE Marlborough
    Longmead House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brunton
    Collingbourne Kingston
    SN8 3SE Marlborough
    Longmead House
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164511360001
    FETTERMAN, Norman
    10 Elm Walk
    NW3 7UP London
    Amministratore
    10 Elm Walk
    NW3 7UP London
    United KingdomBritish3449180002
    GARSTON, Clive Richard
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12179600001
    GELLER, Shmuel
    35 Ahava Street
    Hod Hasharon
    Israel
    Amministratore
    35 Ahava Street
    Hod Hasharon
    Israel
    IsraelIsraeli115779990001
    HANSON, Ian
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    Amministratore
    Poland Street
    W1F 7NN London
    55
    England
    United KingdomBritish230265630001
    HAYIM, Robert
    Arkwright Road
    NW3 6AA London
    The New House
    United Kingdom
    Amministratore
    Arkwright Road
    NW3 6AA London
    The New House
    United Kingdom
    EnglandBritish44229740001
    KANABAR, Haresh Damodar
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    18
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    18
    EnglandBritish51952570001
    KOTECHA, Manish Morarji
    Citibase, Imperial House
    St. Nicholas Circle
    LE1 4LF Leicester
    Suite 9
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Citibase, Imperial House
    St. Nicholas Circle
    LE1 4LF Leicester
    Suite 9
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish174967020001
    LEADER CRAMER, Brian Victor
    Edgewood 21 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JS Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Edgewood 21 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JS Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish67435370001
    MARKS, Simon
    28 Miriam Hahashmonait
    Modin
    Israel
    Amministratore
    28 Miriam Hahashmonait
    Modin
    Israel
    IsraelBritish133347950001
    MATCHETT, Anthony Roland
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish148189460002
    NICOLSON, Sean
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    Amministratore
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    United KingdomBritish199491380001
    RAINGOLD, Gerald Barry
    12 Marston Close
    Swiss Cottage
    NW6 4EU London
    Amministratore
    12 Marston Close
    Swiss Cottage
    NW6 4EU London
    EnglandBritish4418620001
    READ, Peter Graham
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish286091230001
    READ, Peter Graham
    Camden Wharf
    28 Jamestown Road
    NW1 7BY London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    Camden Wharf
    28 Jamestown Road
    NW1 7BY London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish185076600001
    REDMOND, Peter
    Devonshire Road
    N13 4QU London
    27
    England
    Amministratore
    Devonshire Road
    N13 4QU London
    27
    England
    EnglandBritish84787130001
    SAGI, Efraim
    10 Havradim Street
    Ganey Yehuda
    Ganey Yehuda
    Israel
    Amministratore
    10 Havradim Street
    Ganey Yehuda
    Ganey Yehuda
    Israel
    Israeli115779820001
    THERON, Sebastian
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    Amministratore
    370 Gray's Inn Road
    WC1X 8BB London
    The Lighthouse
    England
    EnglandBritish230266120001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per NAPSTER GROUP PLC?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    01 mag 2018La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    NAPSTER GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2021
    Consegnato il 19 apr 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The instrument includes a charge over the assets of the chargor specified in section 3, including any land and all intellectual property of the chargor, including (without limitation) those domain names of the chargor which are set out in schedule 4, for example 'melodyvrplc.com' and 'mvr.group'. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Davis Partnership, LP
    Transazioni
    • 19 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 apr 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2021
    Consegnato il 09 apr 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The instrument includes a charge over all assets of the chargor, including any land and all intellectual property of the chargor. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Davis Partnership, LP
    Transazioni
    • 09 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 apr 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2020
    Consegnato il 11 gen 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    If required on written demand from the lender a first fixed charge over all intellectual property of melody vr group PLC and associated goodwill.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Davis Partnership, LP
    Transazioni
    • 11 gen 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0