LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED
Panoramica
Nome della società | LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05640866 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | One Curzon Street W1J 5HD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Andrew Peter Jeanes come amministratore in data 01 mag 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Fry come amministratore in data 20 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Mark Bull come amministratore in data 19 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Lasalle Blooms General Partner Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Louise Lloyd come segretario in data 17 giu 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Muscat come amministratore in data 07 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Sarah Louise Lloyd come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Pollard come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANES, Andrew Peter | Amministratore | W1J 5HD London One Curzon Street | England | British | Director | 154587750001 | ||||
TRIPP, Alan | Amministratore | W1J 5HD London One Curzon Street England | England | British | Investment Manager | 95742310002 | ||||
WATSON, Stuart John Richmond | Amministratore | W1J 5HD London One Curzon Street England | England | British | Company Director | 123963840001 | ||||
LLOYD, Sarah Louise | Segretario | W1J 5HD London One Curzon Street England | 182726320001 | |||||||
POLLARD, Martin Lewis | Segretario | W1J 5HD London One Curzon Street England | British | 38382990001 | ||||||
BRISTOWS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 3 Lincoln's Inn Fields WC2A 3AA London | 82821680001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BROWN, Justin Ward | Amministratore | 18 Lightfoot Road N8 7JN London | England | British | Investment Manager | 117550300001 | ||||
BULL, Andrew Mark | Amministratore | W1J 5HD London One Curzon Street England | United Kingdom | British | Investment Manager | 92109140001 | ||||
FRY, Christopher John | Amministratore | Itchenor Road Itchenor PO20 7DH Chichester Goose Barn West Sussex England | United Kingdom | British | Fund Manager | 116534710002 | ||||
LYON, James Scott | Amministratore | W1J 5HD London One Curzon Street England | England | British | Accountant | 110229280001 | ||||
MANLEY, Peter Malcolm | Amministratore | 3 Preston Park ME13 8LH Faversham Kent | British | Accountant | 1298410001 | |||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | Thistlecroft Meadow Bank Ockham Road South KT24 6SW East Horsley | United Kingdom | British | Investment Banker | 58478890003 | ||||
MUSCAT, Andrew John | Amministratore | Flock Mill Place Earlsfield SW18 4QJ London 13 England | United Kingdom | Maltese | Accountant | 134879490002 | ||||
REDFORD, Iain | Amministratore | 5 Park Row SE10 9NG London | British | Solicitor | 106908770001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasalle Blooms General Partner Limited | 06 apr 2016 | W1J 5HD London One Curzon Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Lasalle Blooms General Partner Limited | 06 apr 2016 | W1J 5HD London One Curzon Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LASALLE BLOOMS NOMINEE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 07 ago 2008 Consegnato il 27 ago 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property known as stevenage garden centre graveley road stevenage t/n’s HD392392 and HD451251, all buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 ago 2008 Consegnato il 27 ago 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property known as st mellons garden centre newport road cardiff t/n’s WA652616 and CYM297687, all buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 ago 2008 Consegnato il 27 ago 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property known as blooms garden centre oxford road bicester oxfordshire t/n ON218979 all buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 04 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the mortgagors to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H stevenage garden centre gravley road stevenage t/nos HD392392 and HD451251 including all rights and all buildings fixtures fittings plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 04 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the mortgagors to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H blooms garden centre oxford road bicester oxfordshire t/no ON218979 including all rights and all buildings fixtures fittings plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 04 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the mortgagors to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H st mellons garden centre newport road cardiff t/nos WA652616 and CYM297687 and the strip of land between those registered titles including all rights and all buildings fixtures fittings plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0