MIDAZ LASERS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MIDAZ LASERS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05665271 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MIDAZ LASERS LIMITED?
- fabbricazione di strumenti ottici di precisione (26701) / Industrie manifatturiere
Dove si trova MIDAZ LASERS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 2 Newnham Drive NN11 8YN Daventry England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MIDAZ LASERS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MIDAZ LASERS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 28 set 2019 | 17 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 03 feb 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da St. Thomas Place Cambridgeshire Business Park Ely Cambridgeshire CB7 4EX a Unit 2 Newnham Drive Daventry NN11 8YN in data 13 dic 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 056652710001 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 29 set 2018 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stuart David Clark come segretario in data 23 nov 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Stuart David Clark come amministratore in data 23 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Douglas Gray Stark come segretario in data 23 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Douglas Gray Stark come amministratore in data 23 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 ott 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Douglas Gray Stark come amministratore in data 07 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 056652710001, creata il 07 nov 2016 | 59 pagine | MR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 37 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MIDAZ LASERS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARK, Stuart David | Segretario | Acre Road, West Of Scotland Science Park Maryhill Road G20 0XA Glasgow Todd Campus Scotland | 252977010001 | |||||||
| CLARK, Stuart David | Amministratore | West Of Scotland Science Park Maryhill Road G20 0XA Glasgow Todd Campus Scotland | Scotland | British | 252939510001 | |||||
| DIMARCO, Bret | Amministratore | Newnham Drive NN11 8YN Daventry Unit 2 England | United States | American | 171005380001 | |||||
| HUNTER, Daniel Allen | Amministratore | 5100 Patrick Henry Drive Santa Clara Coherent Inc California 95054 United States | United States | American | 207215840001 | |||||
| MCPEEK, Mitchell Arnold | Amministratore | Newnham Drive NN11 8YN Daventry Unit 2 England | United States | American | 177355210001 | |||||
| DIMARCO, Bret | Segretario | Cambridgeshire Business Park CB7 4EX Ely St. Thomas Place Cambridgeshire | British | 171007810001 | ||||||
| ELLISON, John Kevin | Segretario | 3 Lansdown Crescent BA1 5EX Bath | British | 62422910001 | ||||||
| PATERSON, Alexander Nicholas | Segretario | 92 Addison Gardens W14 0DR London | British | 120522570001 | ||||||
| STARK, Douglas Gray | Segretario | Todd Campus Maryhill Road G20 0XA Glasgow Coherent Scotland Ltd Scotland | 179179910001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANTHONY, Robert Byron | Amministratore | Cambridgeshire Business Park CB7 4EX Ely St. Thomas Place Cambridgeshire | Usa | American | 71374680001 | |||||
| ATHERTON, Paul David, Dr | Amministratore | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | United Kingdom | British | 87912060002 | |||||
| DAMZEN, Michael, Professor | Amministratore | 9 Chamberlain Road W13 9EW London | United Kingdom | British | 110221320001 | |||||
| DIETEL, Alfred Kurt | Amministratore | Pettsgrove Avenue HA0 3AF Wembley 38 Middlesex | England | German | 117191470001 | |||||
| MAY, Paul Graham | Amministratore | 121 Stetchworth Road Dullingham CB8 9UH Newmarket Cambridgeshire | England | British | 39853900003 | |||||
| SIMONET, Helene | Amministratore | Cambridgeshire Business Park CB7 4EX Ely St. Thomas Place Cambridgeshire | Usa | Belgian | 80121480001 | |||||
| STARK, Douglas Gray | Amministratore | Todd Campus Maryhill Road G20 0XA Glasgow Coherent Scotland Ltd United Kingdom | Scotland | British | 218228690001 | |||||
| TOMBLING, Craig, Dr | Amministratore | Jasmine Cottage Bear Lane OX44 7UR Stadhampton Oxford | England | British | 272885630001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MIDAZ LASERS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 04 gen 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
MIDAZ LASERS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 07 nov 2016 Consegnato il 09 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Nil. Debitore che agisce come trustee nudo: Sì L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0