NORPRINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORPRINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05665731
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORPRINT LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova NORPRINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORPRINT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILLOUGHBY (534) LIMITED04 gen 200604 gen 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORPRINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per NORPRINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 lug 2020

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 lug 2019

    30 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 lug 2018

    27 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    18 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 dic 2016

    33 pagine2.24B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    29 pagine2.39B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 giu 2016

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 29 gen 2016

    22 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    15 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Horncastle Road Boston Lincolnshire PE21 9HZ a Mazars House Gelderd Road Gildersome Leeds Yorkshire LS27 7JN in data 17 ago 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2015

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di NORPRINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Segretario
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    BritishAccountant130150960001
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Amministratore
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director152573210001
    COLCLOUGH, Roy Harry
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Amministratore
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector56053020001
    JOHNSON, Paul Rowland
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Amministratore
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Sales Director71509040002
    LAIDLAW, Alan
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Amministratore
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector65449270007
    WISE, John Robert
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Amministratore
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDivisional Director149016400001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant121161680001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Segretario
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    68522760005
    DOVE, Nicholas Charles
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Amministratore
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director107550720001
    FAWDINGTON, Eric Alexander
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Amministratore
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    EnglandBritishNon-Executive Director59580130001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector121161680001
    FRENCH, Nicholas Gordon
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    Amministratore
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant71509080001
    SEN, Jaidip
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    Amministratore
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    EnglandBritishAccountant136029390001
    SHOOTER, Michael William
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Amministratore
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishProduction Director66802990002
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Amministratore
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    95689040001

    NORPRINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 dic 2013
    Consegnato il 17 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 ago 2012
    Consegnato il 29 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Nortag dynamic rf/rfid security tag laminator serial no M677 (rebuilt 2005), mark andy 4150-16B 16" 4 colour flexopress converter serial no 1005580 (1998) and mark andy norprint po washer tag converter serial no 061102 (for full list of mortgaged chattels please see form MG01) fixed charge all plant and machinery and the benefit of all rights and claims in respect of the design construction repair or replacement of the same see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Creato il 22 ago 2012
    Consegnato il 29 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Bank Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Creato il 22 ago 2012
    Consegnato il 29 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 28 apr 2011
    Consegnato il 04 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 03 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge on all plant and machinery being- arsoma EM410 8 colour flexopress printing line s/no 410-293. arsoma EM410 13 station modular litho/flexopress printing line s/no 410-218. additional interchangeable modules including 3 x 24" litho printing heads (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 apr 2010
    Consegnato il 23 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fised charges all its plant and machinery,the benefit of all the company's rights and claims,the benefits arising under the policies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 16 apr 2010
    Consegnato il 23 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • G E Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 31 gen 2008
    Consegnato il 06 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £150,000.00 in a seprate interest-earning deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Norcros Estates Limited
    Transazioni
    • 06 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 15 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited and magnadata group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Securities Limited
    Transazioni
    • 15 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 14 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 14 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)

    NORPRINT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 lug 2015Inizio dell'amministrazione
    22 lug 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praticante
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    2
    DataTipo
    22 lug 2017Inizio della liquidazione
    23 giu 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praticante
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Conrad Alexander Pearson
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praticante
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0