CASTLE COVER LIMITED

CASTLE COVER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLE COVER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05698370
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLE COVER LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CASTLE COVER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ageas House Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLE COVER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NUMBERONECORP LIMITED06 feb 200606 feb 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE COVER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE COVER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2016

    Stato del capitale al 10 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Anthony Edward Middle come amministratore in data 01 ott 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter James Corfield come amministratore in data 01 ott 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2015

    Stato del capitale al 10 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Varie

    Section 519 ca 2006
    2 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 feb 2014

    Stato del capitale al 14 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Ageas House Tollgate Eastleigh Hampshire SO53 3YA United Kingdom* in data 30 set 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Watson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Friend come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Fernley Dyson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Collins come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Cliff come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Bright come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    18 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Stato del capitale al 25 apr 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    Chi sono gli amministratori di CASTLE COVER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Rosemary
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    159166410001
    LEMANS, Nicholas James
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish114355520003
    MIDDLE, Anthony Edward
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United KingdomBritish129283070001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Segretario
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    LEPPINGTON, Peter Edward
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    Segretario
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    English109752090001
    PREBBLE, Ashley Brett
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Segretario
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    British94781040001
    PREBBLE, Ashley Brett
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Segretario
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    British94781040001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Segretario nominato
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BOYES, Andrew Charles
    62 Barn Piece
    Chandlers Ford
    SO53 4HR Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    62 Barn Piece
    Chandlers Ford
    SO53 4HR Eastleigh
    Hampshire
    British98554230001
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    BRIGHT, Robert Stewart
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish145809660001
    CARTER, Patrick Robert, Lord
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    Amministratore
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    United KingdomBritish6338850001
    CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice
    Heronspool
    Accommodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Amministratore
    Heronspool
    Accommodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    British5828350003
    CLIFF, Mark
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish197694550001
    COLE, Andrew John
    39 High Street
    EX10 9SH Sidford
    Greenacres
    Devon
    Amministratore
    39 High Street
    EX10 9SH Sidford
    Greenacres
    Devon
    British137614980001
    COLLINS, James William
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160150700001
    CONNOR, Janet
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish77312440003
    CORFIELD, Peter James
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish163452900001
    DYSON, Fernley Keith
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127180610001
    FRIEND, Peter Richard Henry
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish14914420007
    HARVEY, Julian Robert Mark
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish161523620001
    HOWE, Sarah Anne
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish147052720002
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Amministratore
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritish33901640008
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Amministratore
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritish33901640008
    LEPPINGTON, Peter Edward
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    Amministratore
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    EnglandEnglish109752090001
    MARCHINGTON, Andrew Philip
    Hillcrest
    19 Brudenell Avenue
    BH13 7NW Poole
    Dorset
    Amministratore
    Hillcrest
    19 Brudenell Avenue
    BH13 7NW Poole
    Dorset
    EnglandBritish114691900001
    MORLEY HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Amministratore
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    British80334700004
    MORLEY-HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Amministratore
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    AntiguaBritish156236170001
    MURRAY, Alastair Neil
    Viewfield Road
    SW18 5JE Wandsworth
    22
    London
    Amministratore
    Viewfield Road
    SW18 5JE Wandsworth
    22
    London
    United KingdomBritish124855970002
    READER, James Owen
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    Amministratore
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    British112551820001
    READER, James Owen
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    Amministratore
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    British112551820001
    SMITH, Barry Duncan
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish47378680003
    SMYTH, Timothy John
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    Amministratore
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish77794000002
    WATSON, Andrew Stuart
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish124578530001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Amministratore delegato nominato
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    CASTLE COVER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 05 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 19 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Axa Insurance UK PLC
    Transazioni
    • 19 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2006
    Consegnato il 27 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0