GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED

GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05716360
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    35 Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAWGRA (NO. 1225) LIMITED21 feb 200621 feb 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Annick Agnes Bredero come amministratore in data 04 apr 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maurice Alexander Kalsbeek come amministratore in data 04 apr 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Amy Nicole Lejune come amministratore in data 11 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Christopher Vijselaar come amministratore in data 11 dic 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 057163600005, creata il 01 mar 2017

    22 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 057163600004, creata il 23 feb 2017

    52 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 057163600003, creata il 23 feb 2017

    28 pagineMR01

    Nomina di Mr Gerardus Johannes Schipper come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Raoul Rene Hofland come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Intertrust (Uk) Limited come segretario in data 23 feb 2017

    2 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teacher Stern Llp 37-41 Bedford Row London WC1R 4JH a 35 Great St Helen's London EC3A 6AP in data 28 feb 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Maurice Alexander Kalsbeek come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Christopher Vijselaar come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Emlyn Peter Reid come amministratore in data 23 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Melissa Gabrielle Bourgeois come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Segretario
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06307550
    188126550001
    BOURGEOIS, Melissa Gabrielle
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomBritish222397120001
    BREDERO, Annick Agnes
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutch244929000001
    HOFLAND, Raoul Rene
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    NetherlandsDutch203934820001
    LEJUNE, Amy Nicole
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomAmerican216235620001
    SCHIPPER, Gerardus Johannes
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    NetherlandsDutch172791800001
    CREIGHTON, David Andrew
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Segretario
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    British83528100001
    SHERLOCK, Ian Montague
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    Segretario
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    British106839080001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BOYD, Francis Edward
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Amministratore
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Northern IrelandNorthern Irish83528370002
    BURNETT, Graham Alan
    17 Church Street
    Colne Engaine
    CO6 2EX Colchester
    Essex
    Amministratore
    17 Church Street
    Colne Engaine
    CO6 2EX Colchester
    Essex
    United KingdomBritish111805410001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Amministratore
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritish83528100001
    HUNTER, Colin Stewart
    11 Longworth Road
    Egerton
    BL7 9TS Bolton
    Greater Manchester
    Amministratore
    11 Longworth Road
    Egerton
    BL7 9TS Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritish53084060001
    KALSBEEK, Maurice Alexander
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutch199209280001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Amministratore
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Northern IrelandBritish75236310001
    SHERLOCK, Ian Montague
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish106839080001
    VIJSELAAR, Daniel Christopher
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Amministratore
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutch195333960001
    WALDEN, Robert Graham
    Mapletons
    Crawley End, Chrishall
    SG8 8QN Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Mapletons
    Crawley End, Chrishall
    SG8 8QN Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish65156020001
    WILLIAMS, Guy Rodney
    346 The Chase
    SS7 3DN Benfleet
    Essex
    Amministratore
    346 The Chase
    SS7 3DN Benfleet
    Essex
    EnglandBritish100570560001
    WHALE ROCK DIRECTORS LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Amministratore delegato nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900019450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    23 feb 2017
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10563127
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    21 feb 201716 mar 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 mar 2017
    Consegnato il 06 mar 2017
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole the land known as gyle shopping centre, south gyle broadway, edinburgh, EH12 9JY, the registered proprietor's interest in which land being registered in the land register of scotland under title number MID91568 together with free ish and entry to and from the said land by south gyle broadway.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Common Security Agent)
    Transazioni
    • 06 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 feb 2017
    Consegnato il 03 mar 2017
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee for Each of the Secured Parties (the "Common Security Agent"))
    Transazioni
    • 03 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 feb 2017
    Consegnato il 02 mar 2017
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Common Security Agent)
    Transazioni
    • 02 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2006
    Consegnato il 24 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/10/2006 and
    Creato il 05 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Gyle shopping centre south gyle lying on or towards the north, northeast side of south gyle broadway edinburgh midlothian t/no MID91568 the parts privileges and pertinents fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0