HILLPEDAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHILLPEDAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05739872
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HILLPEDAL LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova HILLPEDAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Castlegate House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HILLPEDAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HILLPEDAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HILLPEDAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ a Castlegate House 36 Castle Street Hertford Hertfordshire SG14 1HH in data 19 feb 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 feb 2015

    LRESEX

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    4 pagine2.33B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    13 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Nomina di un curatore o di un gestore

    8 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    8 pagineRM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mar 2014

    Stato del capitale al 18 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Robert Savill come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philippa Scobie come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    2 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Philippa Scobie il 10 ott 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Mrs Philippa Scobie come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Morgan come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Patrick O'hara il 21 mar 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di HILLPEDAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SAVILL, Robert
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Segretario
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    176204050001
    DALY, John Francis
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Amministratore
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish78960760003
    O'HARA, Patrick
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Amministratore
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish82724260003
    DUNKLEY, Philippa
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Other124641320003
    MORGAN, David Richard
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Segretario
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    147695980001
    PARKER, Gordon
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Segretario
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Irish85330570001
    SCOBIE, Philippa
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Segretario
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    167237380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HILLPEDAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 dic 2006
    Consegnato il 12 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from anglo fii limited partnership acting by its general partner anglo irish private equity gp (no.23) limited to any of the beneficiaries and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a as the belfry business park, colonial way, watford, hertfordshire t/n HD55936 its interest in: all existing and future fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 12 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 102 ago 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 1
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 october 2006 and
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in the subjects at 56 and 58 bridge street aberdeen t/no ABN21005.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to any of the beneficiaries and from the company to the agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a leisure site 4 parkway birmingham great park west midlands t/no WM696792, f/h property k/a land on the east side of station road swinton salford greater manchester t/nos GM438354 and GM471358, f/h property k/a land on the north side of bone land newbury t/no BK282065 by way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools vehicles, any investment, any hedging agreement and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to any of the beneficiaries and from the company to the agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a alpha and beta house parkside court rooley lane bradford t/no WYK711270, f/h property k/a cedar and beech house manor road horsforth leeds t/no WYK607895, f/h property k/a crown house 81/89 great george street and 18 and 18A leighton street leeds t/no WYK561304 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 202 ago 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 2

    HILLPEDAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Ricevitore/gestore
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Ricevitore/gestore
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Ricevitore/gestore
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Ricevitore/gestore
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    3
    DataTipo
    19 set 2014Inizio dell'amministrazione
    11 nov 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    4
    DataTipo
    05 feb 2015Inizio della liquidazione
    12 lug 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard William James Long
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford
    Praticante
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0