WESSEX DRIVEABILITY
Panoramica
| Nome della società | WESSEX DRIVEABILITY |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 05755738 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WESSEX DRIVEABILITY?
- Attività di medicina specialistica (86220) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova WESSEX DRIVEABILITY?
| Indirizzo della sede legale | Leornain House Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WESSEX DRIVEABILITY?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SOUTHAMPTON MOBILITY CENTRE | 13 nov 2008 | 13 nov 2008 |
| WESSEX DRIVEABILITY | 08 set 2008 | 08 set 2008 |
| SOUTHAMPTON MOBILITY CENTRE | 24 mar 2006 | 24 mar 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WESSEX DRIVEABILITY?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per WESSEX DRIVEABILITY?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2023 | 11 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Cessazione della carica di Ben Philip Chapman come amministratore in data 30 gen 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Nomina di Mrs Ann Frye come amministratore in data 02 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Nomina di Mr Philip Arthur Chapman come amministratore in data 02 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022 | 11 pagine | AA | ||||||
Cessazione della carica di Barrie Patten come amministratore in data 23 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Cessazione della carica di Richard Barnes-Gorell come amministratore in data 27 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021 | 11 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Seconda presentazione per la nomina di Mr Robert Douglas David Heard come amministratore | 3 pagine | RP04AP01 | ||||||
Seconda presentazione per la nomina di Mr Barrie Patten come amministratore | 3 pagine | RP04AP01 | ||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ben Philip Chapman il 08 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||
Nomina di Mr Barrie Patten come amministratore in data 08 apr 2021 | 3 pagine | AP01 | ||||||
| ||||||||
Nomina di Mr Rob Douglas David Heard come amministratore in data 08 apr 2021 | 3 pagine | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cessazione della carica di Peter Francis Hook come amministratore in data 11 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020 | 11 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 11 pagine | AA | ||||||
Cessazione della carica di Martin Richard Gill come amministratore in data 06 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Chi sono gli amministratori di WESSEX DRIVEABILITY?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Paul Richard | Segretario | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | British | 146892090001 | ||||||
| CHAPMAN, Philip Arthur | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 193875070001 | |||||
| FRYE, Ann | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 117954490001 | |||||
| HEARD, Robert Douglas David | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 281808660001 | |||||
| WATSON, Richard | Amministratore | Normanhurst Avenue BH8 9NN Bournemouth 23 England | England | British | 247178590001 | |||||
| CROUCH, Louise Margaret Ruth | Segretario | 5 Stanbury Close Bosham PO18 8NS Chichester West Sussex | British | 108318790001 | ||||||
| DOBSON, Adrian | Segretario | Rose Cottage Upton SP11 0JP Andover Hampshire | British | 101274050001 | ||||||
| TRIMBLE, Caroline | Segretario | Bridge Road Woolston SO19 7GS Southampton 83 Hants | Irish | 128485810001 | ||||||
| BARNES-GORELL, Richard | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 218874200001 | |||||
| CARTER, Nigel | Amministratore | Millbrook Road West SO15 0HW Southampton 211 Solent Business Centre Hampshire | United Kingdom | British | 152798340001 | |||||
| CHAPMAN, Ben Philip | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 247208430002 | |||||
| COE, Isabel | Amministratore | Jessimine Cottage Hoxne Road Weybread IP21 5TT Diss Norfolk | England | British | 71902750001 | |||||
| DOBSON, Adrian | Amministratore | Rose Cottage Upton SP11 0JP Andover Hampshire | British | 101274050001 | ||||||
| FARRALL, Paul Richard | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125954960002 | |||||
| GILL, Martin Richard | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 37283770001 | |||||
| GLASS, Alan Graham | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | England | British | 112911770001 | |||||
| GLOVER, Susan | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 207845180001 | |||||
| GREGORY, Ian | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | England | British | 178865480001 | |||||
| HOOK, Peter Francis | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 8570270001 | |||||
| LONGLEY, Lindsay | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 190466670001 | |||||
| MANKERTZ, Roz | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | England | British | 178865490001 | |||||
| MCKAIGG, Jane | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 192262830001 | |||||
| MCKEY, Joan Isabel | Amministratore | Unit 211 Solent Business Centre Millbrook Road West SO15 0HW Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 125249300001 | |||||
| NEAL, Patricia | Amministratore | Unit 211 Solent Business Centre Millbrook Road West SO15 0HW Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 135938990001 | |||||
| OSMOND, Richard George | Amministratore | Unit 211 Solent Business Centre Millbrook Road West SO15 0HW Southampton Hampshire | England | British | 56187060001 | |||||
| PASSANT, John Edward Trevor | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire United Kingdom | England | British | 2421120008 | |||||
| PASSANT, John Edward Trevor | Amministratore | Providence Chapel TN26 2JX Warehorne Kent | England | British | 2421120008 | |||||
| PATTEN, Barrie | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 281808910001 | |||||
| RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph | Amministratore | The Malt House Upton, Nr Andover SP11 0JS Andover Hampshire | British | 33402910003 | ||||||
| RICHARDSON, Jennifer Mary | Amministratore | Unit 211 Solent Business Centre Millbrook Road West SO15 0HW Southampton Hampshire | England | British | 121572050001 | |||||
| SEDDON, David William | Amministratore | Kent Road Portswood SO17 2LJ Southampton Leornain House Hampshire | England | British | 112362880001 | |||||
| WILLIAMS, David Charles | Amministratore | Elm Cottage The Street Chattisham IP8 3QG Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | 61113330002 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WESSEX DRIVEABILITY?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 24 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
WESSEX DRIVEABILITY ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 26 apr 2011 Consegnato il 05 mag 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company charges as a first legal charge its interest in the account together with all money from time to time in the account or withdrawn from the account in accordance with the deed. The company covenants not to create any further charge encumbrance or security interst over the whole or any part of the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0