PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED

PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARTNERSHIPS NO.1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05772184
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    • Costruzione di opere di urbanizzazione per energia elettrica e telecomunicazioni (42220) / Costruzioni

    Dove si trova PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hartwell House
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARTNERSHIPS FOR RENEWABLES LIMITED06 apr 200606 apr 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da , 2 Hunting Gate, Hitchin, SG4 0TJ, England a Hartwell House 55-61 Victoria Street Bristol BS1 6AD in data 16 gen 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    14 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 dic 2018

    LRESSP

    Nomina di Mr David John Lees come amministratore in data 18 mag 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gareth James Purcell come amministratore in data 18 mag 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2017

    24 pagineAA

    Stato del capitale al 04 gen 2018

    • Capitale: GBP 100.00
    4 pagineSH19

    legacy

    4 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 ago 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 ago 2017

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2017 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Stato del capitale al 09 mar 2017

    • Capitale: GBP 35,432,272.3568
    5 pagineSH19

    legacy

    4 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Cessazione della carica di Mark Christopher Wayment come amministratore in data 20 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Mark Entract come amministratore in data 21 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Edward Hall-Smith come amministratore in data 21 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gareth James Purcell come amministratore in data 20 feb 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2016

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARIO RENEWABLES LTD
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    Segretario
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione09665290
    201819380001
    DELAY, Thomas Auguste Read
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    Amministratore
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    EnglandBritish77940350001
    ENTRACT, Jonathan Mark
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    EnglandBritish86046470002
    HALL, Gina Verissimo
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    Amministratore
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    United StatesAmerican158001080001
    KING, Kenzo Samuel
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    Amministratore
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    EnglandBritish204739480001
    LEES, David John
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    EnglandBritish116201520007
    MCCORMICK, Morgan James
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    Amministratore
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    EnglandCanadian181090450002
    VINCE, Simon Owen
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    Amministratore
    55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Hartwell House
    EnglandBritish204740060001
    O'GRADY, Leigh Anne
    c/o C/O The Carbon Trust
    27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    Dorset House
    England
    Segretario
    c/o C/O The Carbon Trust
    27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    Dorset House
    England
    195626940001
    STOCKWELL, Anthony Howard
    Five Farthings
    Mansel Road Wimbledon
    SW19 4AA London
    Segretario
    Five Farthings
    Mansel Road Wimbledon
    SW19 4AA London
    British88273130001
    WILLIAMS, Claire Anne
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    Segretario
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    152389260001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Road
    B3 2AS Birmingham
    Segretario
    55 Colmore Road
    B3 2AS Birmingham
    102981550001
    AINGER, Stephen David
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    Amministratore
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    EnglandBritish131477050001
    BOOT, Rosemary Jane Cecilia
    71 Bute Gardens
    W6 7DX London
    Amministratore
    71 Bute Gardens
    W6 7DX London
    United KingdomBritish77940300001
    CRAWFORD, William Richard
    Stoke Cottage
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Stoke Cottage
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish75140530002
    HALL-SMITH, James Edward
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    Amministratore
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    United KingdomBritish128011730001
    KOLENC, Stanislav Michael
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    Amministratore
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    EnglandCanadian155972200001
    MOORE, Alan Geoffrey
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    Amministratore
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    United KingdomBritish59113970001
    PURCELL, Gareth James
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    EnglandBritish132809610003
    RICHON, Thibault Francois Paul
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    Amministratore
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    EnglandFrench181090670001
    WALSH, John Matthew
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    Amministratore
    Floor
    Dorset House 27-45 Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th
    England
    CanadaCanadian155972110001
    WAYMENT, Mark Christopher
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    Amministratore
    Hunting Gate
    SG4 0TJ Hitchin
    2
    England
    United KingdomBritish62992220002
    WORDSWORTH, Andrew Christopher
    Great Brooks
    The Green Leigh
    TN11 8QR Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Great Brooks
    The Green Leigh
    TN11 8QR Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish110729710001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Road
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore
    55 Colmore Road
    B3 2AS Birmingham
    102981540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Carbon Trust Enterprises Limited
    Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th Floor, Dorset House, 27-45
    England
    06 apr 2016
    Stamford Street
    SE1 9NT London
    4th Floor, Dorset House, 27-45
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione05113991
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Infrared Environmental Infrastructure Gp Limited
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    06 apr 2016
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione06475352
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Optrust Scots I Limited (General Partner Of Oaxaca Scots L.P.)
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    06 apr 2016
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc398177
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 28 nov 2012
    Consegnato il 01 dic 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from partnerships for renewables cwfl holdco limited to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the shares, by way of equitable mortgage the distribution rights from time to time accruing to or on the shares and by way of fixed charge the secured property and all interest in the secured property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ventus Vct PLC as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Share charge
    Creato il 08 mag 2012
    Consegnato il 10 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from partnerships for renewables construction holdco limited to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its present and future shares being 2 ordinary shares of £1 each see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Infrared Environmental Infrastructure Gp Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge of deposit
    Creato il 26 apr 2012
    Consegnato il 02 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £560,000 and all amounts in the future credited to account number 24169955 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 24 apr 2008
    Consegnato il 26 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The bank account of the company named ctel turbine deposit account number 00257975 including all cash amounts, any near cash instruments, all rights in any other certificate of deposit, all interest arising on the account.
    Persone aventi diritto
    • Carbon Trust Enterprises Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)

    PARTNERSHIPS NO.1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 dic 2018Inizio della liquidazione
    03 mag 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Guy Boughey
    Hartwell House 55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Avon
    Praticante
    Hartwell House 55-61 Victoria Street
    BS1 6AD Bristol
    Avon
    Diana Frangou
    St Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praticante
    St Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0