HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED

HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05772424
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Egyptian Mill
    Egyptian Street
    BL1 2HS Bolton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STORE FIRST MIDLANDS LIMITED28 feb 201428 feb 2014
    HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED01 lug 201001 lug 2010
    DYLAN HARVEY COMMERCIAL LIMITED06 apr 200606 apr 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore da parte dei creditori

    2 pagineLIQ07

    Indirizzo della sede legale modificato da Group First House Mead Way Padiham Lancs BB12 7NG a Egyptian Mill Egyptian Street Bolton BL1 2HS in data 22 dic 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 28 nov 2022

    LRESEX

    Cessazione della carica di Toby Scott Whittaker come amministratore in data 01 ago 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Ruth Margaret Almond come amministratore in data 01 lug 2022

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Slater come amministratore in data 01 apr 2022

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 057724240045, creata il 22 dic 2021

    17 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 057724240046, creata il 22 dic 2021

    17 pagineMR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2020

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 giu 2020 al 28 giu 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ruth Margaret Almond come amministratore in data 30 apr 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Leanne Gregson come amministratore in data 30 apr 2019

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name30 apr 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 apr 2019

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2018

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALMOND, Ruth Margaret
    Egyptian Street
    BL1 2HS Bolton
    Egyptian Mill
    Amministratore
    Egyptian Street
    BL1 2HS Bolton
    Egyptian Mill
    EnglandBritishDirector198721490002
    BUJAKOWSKI, Peter Jan
    Bank House 7 Main Street
    Warton
    LA5 9NR Carnforth
    Lancashire
    Segretario
    Bank House 7 Main Street
    Warton
    LA5 9NR Carnforth
    Lancashire
    BritishSolicitor25558140002
    GAHAN, Richard John
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    Segretario
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    195586130001
    GAHAN, Richard John
    9 Linley Grove
    Holcombe Brook
    BL0 9TS Bury
    Lancashire
    Segretario
    9 Linley Grove
    Holcombe Brook
    BL0 9TS Bury
    Lancashire
    British111788640001
    TURNER, John Michael
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    Segretario
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    British133028940001
    ALMOND, Ruth Margaret
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    Amministratore
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    EnglandBritishDirector198721490002
    GREGSON, Leanne
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    Amministratore
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompletion Manager168216380002
    NORRIS, Kenneth Philip
    Brockhall Village
    BB6 8BA Old Langho
    Stonyhurst View
    Lancs
    Amministratore
    Brockhall Village
    BB6 8BA Old Langho
    Stonyhurst View
    Lancs
    United KingdomBritishCommercial Director150753510001
    PICKERING, Claire
    Empire Business Park
    Empire Way
    BB12 6HA Rose Grove
    Business First Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Empire Business Park
    Empire Way
    BB12 6HA Rose Grove
    Business First Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector160354040001
    SLATER, John
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    Amministratore
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector98012630001
    TALBOT, Stephen Michael
    Apt 518 Quebec Building
    Bury Street
    M3 7DU Salford
    Manchester
    Amministratore
    Apt 518 Quebec Building
    Bury Street
    M3 7DU Salford
    Manchester
    EnglandBritishCompany Director111088830002
    WHITTAKER, Toby Scott
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    Amministratore
    Mead Way
    BB12 7NG Padiham
    Group First House
    Lancs
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director165950350001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mead Way
    Padiham
    BB12 7NG Burnley
    Group First House
    England
    06 apr 2017
    Mead Way
    Padiham
    BB12 7NG Burnley
    Group First House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4627975
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2021
    Consegnato il 11 gen 2022
    In corso
    Breve descrizione
    Unit 214, mead court business centre, davyfield road, blackburn BB1 2QY registered at hm land registry under title number LAN82260.. For details of more land charged please refer to schedule 1 in the instrument.. All of the borrower's intellectual property rights as defined in the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Charles Street Commercial Investments Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2021
    Consegnato il 11 gen 2022
    In corso
    Breve descrizione
    Unit 214 mead court business centre, davyfield road, blackburn BB1 2QY registered at hm land registry under title number LAN82260.. For details of more land charged please refer to the "schedule of property" in the instrument.. All estates or interests in the property.. By way of equitable mortgage, all equitable interests in the property which now or may in the future belong to the borrower (including for the avoidance of doubt the right to receive a transfer, or to direct the transfer, of any shares or membership rights which the borrower holds in any company or association connected with the property).. The goodwill and any intellectual property relating to any business carried on by the borrower at the property.. Any mortgage or charge of the property includes;. (1) all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on the property; and. (2) the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the borrower in respect of the property or any moneys paid or payable in respect of those covenants.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Charles Street Commercial Investments Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 310 empire business park, burnley t/no LAN106717.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 226 empire business park, burnley t/no LAN116161.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 223 empire business park, burnley t/no LAN106716.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 218 empire business park, burnley t/no LAN106714.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 128 empire business park, burnley t/no LAN116162.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 127 empire business park, burnley t/no LAN116163.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 109 empire business park, burnley t/no LAN106712.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 24 empire business park, burnley t/no LAN106711.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 23 empire business park, burnley t/no LAN106710.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 19 empire business park, burnley t/no LAN106709.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 14 empire business park, burnley t/no LAN106708.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 20 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £83,333.33 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 13 empire business park, burnley t/no LAN106707.
    Persone aventi diritto
    • F. Gaughran, E. Colhoun, F. Crowley & B. O'hagan
    Transazioni
    • 20 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of assignment of rent
    Creato il 25 nov 2010
    Consegnato il 01 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rents, licence fees and other monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 01 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of assignment of rent
    Creato il 25 nov 2010
    Consegnato il 01 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rents, licence fees and other monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 01 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2010
    Consegnato il 09 nov 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties k/a commercial units 1 to 20, 101 to 124, 201 to 224 and 301 to 324 block a and 1 to 20, 101 to 124, 201 to 224 and 301 to 324 block b liverpool airport business centre, goodlass road, speke, liverpool and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 09 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 19 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H unit 106 mead court business cente davyfield road blackburn t/no:LAN82098 and all buildings structures fixtures(including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment first fixed charge all the right title and interest in any proceeds of insurance any present and future goodwill floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 19 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 113, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82138 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h proeprty known as unit 109, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82105 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank or Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 215, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82264 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilites due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 116, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82185 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 111, mead court business centre, davyfield road, blackburn t/n LAN82132 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilties due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 112, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82126 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 05 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h property known as unit 209, mead court business centre, davyfield road, blackburn, t/n LAN82230 and all buildings, structures, fixtures and fixed plant, machinery and equipment at any time theron.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 05 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 nov 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)

    HARLEY SCOTT COMMERCIAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 nov 2023Data prevista di scioglimento
    28 nov 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart Rathmell
    Egyptian Mill Egyptian Street
    BL1 2HS Bolton
    Lancashire
    Praticante
    Egyptian Mill Egyptian Street
    BL1 2HS Bolton
    Lancashire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0