IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED

IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05780320
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di editoria (58190) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vineyard House 44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAGICALIA MEDIA LIMITED30 ott 200630 ott 2006
    BROOMCO (4009) LIMITED13 apr 200613 apr 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Pierre Bureau il 27 ago 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen James Lavin il 11 apr 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 057803200004 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 057803200005 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 057803200003 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Bond Pearce Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA United Kingdom a Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vineyard House 44 Brook Green Hammersmith London W6 7BT

    1 pagineAD04

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    10 pagineAA

    legacy

    43 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Pierre Bureau il 16 set 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 13 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2016

    Stato del capitale al 14 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONLON, Katherine
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    Segretario
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    British164487920001
    BUREAU, Thomas Pierre
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    Amministratore
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    EnglandBritishCompany Director131456290017
    LANGFORD, Kevin Donald
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    Amministratore
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone85519940001
    LAVIN, Stephen James
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    Amministratore
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United KingdomBritishCompany Director108421120001
    LAVIN, Stephen James
    15 Coombe Gardens
    HP4 3PA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    15 Coombe Gardens
    HP4 3PA Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director108421120001
    TAPP, Jeremy, Mr.
    18 Watcombe Cottages
    Kew
    TW9 3BD Richmond
    Surrey
    Segretario
    18 Watcombe Cottages
    Kew
    TW9 3BD Richmond
    Surrey
    British116397970001
    DAVIES, Owen Wyn
    SW20
    Amministratore
    SW20
    United KingdomBritishDirector45241980002
    EASINGWOOD, Timothy Edward
    Iffley Road
    W6 0PF London
    76
    Amministratore
    Iffley Road
    W6 0PF London
    76
    United KingdomBritishNon Executive Director131609200001
    GRAHAM, Christopher Michael
    Old Buckhurst
    TN7 4BA Withyham
    East Sussex
    Amministratore
    Old Buckhurst
    TN7 4BA Withyham
    East Sussex
    United KingdomBritishNon Executive Director141420530001
    HARKNESS, Peter
    58 Bretton Lane
    West Bretton
    WF4 4LE Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    58 Bretton Lane
    West Bretton
    WF4 4LE Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector109370340001
    LAIRD, Adam
    32 Glycena Road
    SW11 5TR London
    Amministratore
    32 Glycena Road
    SW11 5TR London
    BritishDirector66495720004
    LENANE, James Richard
    29 Bushwood Road
    TW9 3BG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    29 Bushwood Road
    TW9 3BG Richmond
    Surrey
    UkBritishDirector108397470001
    TAPP, Jeremy, Mr.
    18 Watcombe Cottages
    Kew
    TW9 3BD Richmond
    Surrey
    Amministratore
    18 Watcombe Cottages
    Kew
    TW9 3BD Richmond
    Surrey
    BritishDirector116397970001
    TICKELL, Duncan Christopher
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    1
    Amministratore
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    1
    EnglandBritishPublishing Director131456350001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    44 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7BT London
    Vineyard House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07635200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 set 2015
    Consegnato il 10 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 mag 2014
    Consegnato il 06 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 set 2013
    Consegnato il 19 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as the Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creato il 31 ott 2011
    Consegnato il 09 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Acquisition agreement claims, insurance policies, hedging agreements, bbc agreement, lonely planet trade mark licence and structural intra-group loans see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In It's Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 16 ago 2006
    Consegnato il 04 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Current account number 50489158 barclays bank PLC re broomco (4009) limited and fixed treasury deposit. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0