IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05780320 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di editoria (58190) / Informazione e comunicazione
Dove si trova IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Vineyard House 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MAGICALIA MEDIA LIMITED | 30 ott 2006 | 30 ott 2006 |
BROOMCO (4009) LIMITED | 13 apr 2006 | 13 apr 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Pierre Bureau il 27 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen James Lavin il 11 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 057803200004 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 057803200005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 057803200003 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Bond Pearce Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA United Kingdom a Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oceana House 39-49 Commercial Road Southampton SO15 1GA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vineyard House 44 Brook Green Hammersmith London W6 7BT | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 43 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Pierre Bureau il 16 set 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONLON, Katherine | Segretario | 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London Vineyard House United Kingdom | British | 164487920001 | ||||||
BUREAU, Thomas Pierre | Amministratore | 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London Vineyard House | England | British | Company Director | 131456290017 | ||||
LANGFORD, Kevin Donald | Amministratore | 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London Vineyard House United Kingdom | United Kingdom | British | None | 85519940001 | ||||
LAVIN, Stephen James | Amministratore | 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London Vineyard House | United Kingdom | British | Company Director | 108421120001 | ||||
LAVIN, Stephen James | Segretario | 15 Coombe Gardens HP4 3PA Berkhamsted Hertfordshire | British | Company Director | 108421120001 | |||||
TAPP, Jeremy, Mr. | Segretario | 18 Watcombe Cottages Kew TW9 3BD Richmond Surrey | British | 116397970001 | ||||||
DAVIES, Owen Wyn | Amministratore | SW20 | United Kingdom | British | Director | 45241980002 | ||||
EASINGWOOD, Timothy Edward | Amministratore | Iffley Road W6 0PF London 76 | United Kingdom | British | Non Executive Director | 131609200001 | ||||
GRAHAM, Christopher Michael | Amministratore | Old Buckhurst TN7 4BA Withyham East Sussex | United Kingdom | British | Non Executive Director | 141420530001 | ||||
HARKNESS, Peter | Amministratore | 58 Bretton Lane West Bretton WF4 4LE Wakefield West Yorkshire | British | Director | 109370340001 | |||||
LAIRD, Adam | Amministratore | 32 Glycena Road SW11 5TR London | British | Director | 66495720004 | |||||
LENANE, James Richard | Amministratore | 29 Bushwood Road TW9 3BG Richmond Surrey | Uk | British | Director | 108397470001 | ||||
TAPP, Jeremy, Mr. | Amministratore | 18 Watcombe Cottages Kew TW9 3BD Richmond Surrey | British | Director | 116397970001 | |||||
TICKELL, Duncan Christopher | Amministratore | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 1 | England | British | Publishing Director | 131456350001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate Media Company Limited | 06 apr 2016 | 44 Brook Green Hammersmith W6 7BT London Vineyard House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
IMMEDIATE MEDIA COMPANY MAGICALIA HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 03 set 2015 Consegnato il 10 set 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 mag 2014 Consegnato il 06 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 set 2013 Consegnato il 19 set 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession and charge | Creato il 31 ott 2011 Consegnato il 09 nov 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Acquisition agreement claims, insurance policies, hedging agreements, bbc agreement, lonely planet trade mark licence and structural intra-group loans see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creato il 16 ago 2006 Consegnato il 04 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Current account number 50489158 barclays bank PLC re broomco (4009) limited and fixed treasury deposit. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0