LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED

LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05808612
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Begbies Traynor
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 dic 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al24 apr 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma08 mag 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al24 apr 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione delle attività

    9 pagineLIQ02

    Indirizzo della sede legale modificato da Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England a C/O Begbies Traynor 40 Bank Street London E14 5NR in data 08 lug 2024

    3 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 03 lug 2024

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England a Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF in data 29 gen 2024

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 91 Wimpole Street London W1G 0EF England a Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF in data 29 gen 2024

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 058086120010 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 24 nov 2023

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 apr 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di James Michael Shindler come amministratore in data 20 mar 2023

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Loudoun Road St John's Wood London NW8 0DL a 91 Wimpole Street London W1G 0EF in data 15 gen 2023

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2021 al 30 dic 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 058086120012, creata il 20 mag 2022

    28 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Daniel Soning il 02 lug 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 058086120011, creata il 28 mag 2021

    29 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kandasamy Vijaishankar come amministratore in data 25 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Baerbel Schuett come amministratore in data 31 mag 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARNETT, David Melvyn
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    United KingdomBritishProperty Developer39132210004
    SONING, Robert Daniel
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    EnglandBritishDirector33156140034
    BARNETT, Timothy Edward
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    Segretario
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    British150400890001
    BOUSABA, Marie-Anne
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    Segretario
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    245754630001
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    Segretario
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    129435210001
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Segretario
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Peter John
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    Amministratore
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales & Marketing Director, Real Estate188188380001
    BARNETT, Timothy Edward
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    Amministratore
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    EnglandBritishSolicitor157663990001
    BERG, Simon Mark
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector66989000001
    BURROW, Robert Philip
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    Amministratore
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    EnglandBritishCompany Director97252420005
    FRANKHAM, Vivienne
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    Amministratore
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant150385630001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritishBanker104442220001
    HENRIKSEN, Troels Bugge
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish,DanishGroup Finance Director44984800004
    HEPBURN, Alastair John Harley
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker114477450001
    MCFADZEAN, Duncan Alistair Henry
    49 Balgreen Road
    EH12 5TY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    49 Balgreen Road
    EH12 5TY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishInvestment Manager115963740001
    MEGGESON, Julian David
    The Malt Cottage
    School Lane Cookham
    SL6 9QN Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Malt Cottage
    School Lane Cookham
    SL6 9QN Maidenhead
    Berkshire
    BritishBanker114481380001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    Amministratore
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    EnglandBritishCompany Director46176700002
    SCHUETT, Baerbel
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    Amministratore
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    EnglandGermanCompany Director150389260002
    SHINDLER, James Michael
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    Amministratore
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    EnglandBritishProperty Developer135533150002
    VIJAISHANKAR, Kandasamy
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    Amministratore
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United KingdomBritishFinance Director150552890002
    WOLFRYD, Oliver
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    Amministratore
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone115187090001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07172291
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 mag 2022
    Consegnato il 24 mag 2022
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Natwest Markets PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 mag 2021
    Consegnato il 07 giu 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Natwest Markets PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 mar 2019
    Consegnato il 04 apr 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    No specific land, ship, aircraft or intellectual property has been charged. For full details of the charges, please refer to the charging document directly.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Beaufort Ventures Ii (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 dic 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 ago 2017
    Consegnato il 18 ago 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Places for People Ventures Operations Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 mar 2015
    Consegnato il 11 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ltg International Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 ago 2013
    Consegnato il 24 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ltg International Limited
    Transazioni
    • 24 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2011
    Consegnato il 07 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other borrower party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ltg International Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Secured deposit deed
    Creato il 12 nov 2010
    Consegnato il 17 nov 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balance which includes the initial deposit. Initial deposit means the sum of £36,000 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Central Limited
    Transazioni
    • 17 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2010
    Consegnato il 03 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, all computers, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Finance Parties( the Security Agent)
    Transazioni
    • 03 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Insurance assignment
    Creato il 03 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policies being: insurer; halifax life, dated 22 august 2006, number ASSH048239, life assured david melvyn barnett, insurer; halifax life dated 12 july 2006, numbered ASSH048242 life assured robert daniel soning, insurer; halifax life dated 13 july 2006, numbered ASSH048238, life assured simon mark berg,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Financeparties (Security Agent)
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group debenture
    Creato il 19 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoevere under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Financeparties)
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 lug 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Robert Appleton
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Melissa Nagi
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0