GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED

GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05829649
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    • Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi (38210) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Triton Street
    NW1 3BF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GLOBAL RENEWABLES UK HOLDINGS LIMITED26 mag 200626 mag 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicola Mary Johnson come amministratore in data 23 mar 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Jennifer Grace Draper come segretario in data 06 gen 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Nicola Mary Johnson come amministratore in data 29 dic 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2016

    Stato del capitale al 21 giu 2016

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Ms Jennifer Grace Draper come segretario in data 08 giu 2016

    2 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY England a 20 Triton Street London NW1 3BF in data 13 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Ailison Louise Mitchell come segretario in data 19 gen 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor, the Venus 1 Old Park Lane Trafford Manchester M41 7HG a Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY in data 06 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 lug 2015

    Stato del capitale al 09 lug 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Michael William O'farrell come amministratore in data 06 nov 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Richard Tremaine come amministratore in data 06 nov 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven Paul Fraser come amministratore in data 06 nov 2014

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2014

    Stato del capitale al 17 lug 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Mr James Richard Tremaine come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRASER, Steven Paul
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    Amministratore
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    EnglandBritish175869500001
    PRIOR, Steven Marc
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    Amministratore
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    EnglandBritish142912290001
    DRAPER, Jennifer Grace
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    Segretario
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    209258800001
    FOY, Simon John
    5 Lindisfarne Close
    Brooklands
    M33 3RB Sale
    Cheshire
    Segretario
    5 Lindisfarne Close
    Brooklands
    M33 3RB Sale
    Cheshire
    British114274460001
    MITCHELL, Ailison Louise
    Towers Business Park
    Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Lend Lease, Adamson House
    England
    Segretario
    Towers Business Park
    Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Lend Lease, Adamson House
    England
    British53150080001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ANDERSON, Thomas Downs
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    Amministratore
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    United KingdomBritish54976140002
    ANDERSON, Thomas Downs
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    Amministratore
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    United KingdomBritish54976140002
    CHAMBERLAIN, Janet Patricia
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    United KingdomBritish51278380001
    COUZENS, Michael William
    Roseberry Close
    B10 9FQ Ramsbottom
    14
    Uk
    Amministratore
    Roseberry Close
    B10 9FQ Ramsbottom
    14
    Uk
    United KingdomBritish152537080001
    EATOUGH, Peter Richard
    212 Myton Road
    CV34 6PS Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    212 Myton Road
    CV34 6PS Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish105395140001
    FRASER, Steven Paul
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    EnglandBritish175869500001
    HOCKADAY, Stephen
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    Amministratore
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    EnglandBritish101894100001
    JOHNSON, Nicola Mary
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    Amministratore
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    United KingdomAustralian164399850003
    KILGOUR, David John
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    EnglandBritish195386090001
    LAWRENSON, Mark Clifford
    17 Louise Sreet
    FOREIGN Nedlands 6009
    Western Australia
    Australia
    Amministratore
    17 Louise Sreet
    FOREIGN Nedlands 6009
    Western Australia
    Australia
    Australian118854460001
    MARTIN, Neil Christopher
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    United KingdomBritish157057180001
    O'FARRELL, Michael William
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    EnglandBritish77541360001
    POINTON, Christopher Richard
    Holmwood Farm
    Greendown
    BA3 4NZ Chewton Mendip
    Somerset
    Amministratore
    Holmwood Farm
    Greendown
    BA3 4NZ Chewton Mendip
    Somerset
    United KingdomBritish142335020001
    SINGH, Naveen David
    902 Imperial Point
    The Qu Ays
    M50 3RB Salford
    Lancashire
    Amministratore
    902 Imperial Point
    The Qu Ays
    M50 3RB Salford
    Lancashire
    Australian118854400001
    TAYLOR, Gary Douglas
    44 Barham Road
    SW20 0ET London
    Amministratore
    44 Barham Road
    SW20 0ET London
    United KingdomAustralian124867200001
    TREMAINE, James Richard
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    EnglandBritish186213810001
    WATSON, Bevan William
    5 Maddox Street
    Mayfair
    W1S 1QD London
    Amministratore
    5 Maddox Street
    Mayfair
    W1S 1QD London
    United KingdomAmerican127858860001
    WRIGHT, Stephen John
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    Amministratore
    Floor, The Venus 1 Old Park Lane
    Trafford
    M41 7HG Manchester
    3rd
    United KingdomBritish52357260002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Global Renewables Lancashire Holdings Limited
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    06 apr 2016
    Triton Street
    NW1 3BF London
    20
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House Uk
    Numero di registrazione05829353
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 mar 2007
    Consegnato il 12 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity and Acting as Junior Security Trustee for and on Behalf Ofthe Beneficiaries (Junior Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 mar 2007
    Consegnato il 13 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest in to and under the assigned documents the document claims and any guarantees warranties licences and/or other agreements, all right title benefit and interest in any account and all receivables book an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity and Acting as Senior Security Trustee
    Transazioni
    • 13 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0