VENICE NEWCO 1 LIMITED
Panoramica
Nome della società | VENICE NEWCO 1 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05839399 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VENICE NEWCO 1 LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MASTERDEW LIMITED | 07 giu 2006 | 07 giu 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 058393990004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 058393990004, creata il 10 ott 2018 | 75 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 058393990002 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 058393990003 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gail Susan Hunter il 10 giu 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John Cody Bradshaw il 10 giu 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerrard Troy il 10 giu 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 058393990003, creata il 01 dic 2015 | 85 pagine | MR01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 25 nov 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Broughton come amministratore in data 21 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Alexander Burrell come amministratore in data 10 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADSHAW, John Cody | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | American | Hotel Real Estate | 175895530001 | ||||
BURRELL, James Alexander | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 192486560001 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | Irish | Finance Director | 185108770001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Human Resources Director | 156206540001 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 104500230001 | ||||
BENNISON, Matthew Edward | Segretario | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | 161749720001 | |||||||
DOUBLEDAY, Timothy | Segretario | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156119030001 | ||||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Segretario | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | Company Secretary | 185108770001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
BENNISON, Matthew Edward | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
BROUGHTON, Sarah | Amministratore | Harewood Place W1S 1BX London 4th Floor 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 170320620001 | ||||
BURRELL, James | Amministratore | 79 Disraeli Road SW15 2DR London | British | Investment Executive | 115775330001 | |||||
CLARKE, Martin Andrew, Dr | Amministratore | 35 The Bromptons Rose Square SW3 6RS London Uk | United Kingdom | British | Partner At Private Equity Hous | 121053560001 | ||||
COLKET, Kevin | Amministratore | 2 Harewood Place W1S 1BX London 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | United States Of America | Senior Vice President, Real Estate Aquisitions | 175895360001 | ||||
COPELAND, Patrick Joseph | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 40574670003 | ||||
DAY, Mark | Amministratore | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | Director | 124446000001 | ||||
DEVLIN, Roger William | Amministratore | Bearehurst Henhurst Cross Lane RH5 4LR Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 100719250001 | ||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Amministratore | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 91011320001 | ||||
FLANAGAN, Sally Deborah | Amministratore | 10 Cobden Hill WD7 7JR Radlett Hertfordshire | England | British | Investment Executive | 116577710001 | ||||
LEVY, Adrian Joseph Morris | Amministratore | 2 Carlisle Gardens HA3 0JX Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 147682410001 | ||||
MACPHERSON, Duncan Muir | Amministratore | 2 Harewood Place W1S 1BX London 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Real Estate Finance | 153229660002 | ||||
NISBETT, Paul Sandle | Amministratore | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | Company Director | 132613500001 | ||||
PUDGE, David John | Amministratore delegato nominato | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VENICE NEWCO 1 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rome Investco Ltd | 06 apr 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
VENICE NEWCO 1 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 10 ott 2018 Consegnato il 11 ott 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 03 dic 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 12 giu 2014 Consegnato il 18 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
English law deed of accession | Creato il 27 feb 2013 Consegnato il 01 mar 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0