TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED
Panoramica
Nome della società | TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05888955 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Tesco House, Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 26 feb 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Ritiro della richiesta di cancellazione della società | 1 pagine | DS02 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2022 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Simon Richard Williams come amministratore in data 25 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di John Gibney come amministratore in data 25 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2021 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2020 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 24 feb 2019 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Gibney il 02 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Alistair Ewan Clark il 01 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 25 feb 2018 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO SECRETARIES LIMITED | Segretario | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 182118090001 | ||||||||||
CLARK, Alistair Ewan, Mr. | Amministratore | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Treasurer | 160520990004 | ||||||||
WILLIAMS, Simon Richard | Amministratore | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | England | British | Acquisition Director | 293302020001 | ||||||||
EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
O'CONNOR, Claudine Elaine | Segretario | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | Assistant Company Secretary | 50295880003 | |||||||||
PHILP, Clive James | Segretario | Oakey Lane SE1 7HN London 25 United Kingdom | British | 140785910001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
PAILEX SECRETARIES LIMITED | Segretario | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551790001 | |||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRASHER, Richard William Peter | Amministratore | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 70633600002 | ||||||||
EADE, Graham Peter | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | New Zealand | Director | 153426190001 | ||||||||
EARP, Neil Timothy | Amministratore | Tesco Plc Tesco House, Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Herts. | British | Company Director | 83045240002 | |||||||||
GIBNEY, John | Amministratore | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | Irish | Assets And Estates Director | 194216530003 | ||||||||
HARTLEY, Johanna Ruth | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 168410960001 | ||||||||
HARTLEY, Johanna Ruth | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 168410960001 | ||||||||
LEWIS, Bryan John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58257940003 | ||||||||
LU, Hongyan Echo | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Chinese | Uk & Roi Property Director | 171720380001 | ||||||||
MAIR, Ian | Amministratore | Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Tesco House Herts. United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Treasurer | 156335170001 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
MOURANT, Nicholas Claud | Amministratore | Tesco House Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 67463160002 | ||||||||
O'HARE, Eamonn | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | Director | 117596190001 | |||||||||
POTTS, David Thomas | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 61624730005 | ||||||||
RENNIE, James Matthew | Amministratore | 23 Queens Road HP4 3HU Berkhamstead Hertfordshire | British | Chartered Surveyor | 99037070001 | |||||||||
RIGBY, Steven Andrew | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Waltham Cross | United Kingdom | British | Surveyor | 161159630001 | ||||||||
RISK, Michael Robert | Amministratore | Highcroft Kelshall Street SG8 9SH Kelshall Hertfordshire | England | British | Director | 70209830002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
STIRLING, Mark Andrew | Amministratore | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | Surveyor | 106882210001 | ||||||||
WHITE, Emily | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 149676640001 | ||||||||
WITHAM, Mark Peter | Amministratore | Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Tesco House Hertfordshire | British | Surveyor | 128610500001 | |||||||||
PAILEX NOMINEES LIMITED | Amministratore | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551780001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesco Aqua (Nominee Holdco) Limited | 06 apr 2016 | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Assigment of rental income dated 19 march 2007 and creation | Creato il 20 mar 2007 Consegnato il 05 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of amendment | Creato il 20 mar 2007 Consegnato il 30 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The partnership secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Allerton road store mather avenue allerton liverpool, ashford middlesex store town lane stanwell staines middlesex and dinnington store undergate road dinnington south yorkshire for details of further property charged please refer to form 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental nominees deed of charge | Creato il 20 mar 2007 Consegnato il 27 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Mather avenue allerton liverpool t/no MS531364, town lane stanwell staines middlesex t/no SYK57772, undergate road dinnington south yorkshire and the land t/no. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 12 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The tenants interest in the head lease of tesco store at western road montrose. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 12 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The tenants interest in the head lease of tesco store at riverside drive dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Interest under the head lease being the tesco store at kingsway west, dundee t/n ANG45174. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Interest under the head lease being the tesco store at nairn road forres t/n MOR6760. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the subjects k/a tesco store nairn road forres t/no MOR6760. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole subjects k/a tesco store western road montrose tayside t/no ANG45239. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole subjects k/a tesco store kingsway west dundee county of angus t/no ANG45174. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Creato il 19 mar 2007 Consegnato il 11 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the subjects k/a tesco store riverside drize dundee tayside t/no ANG45238. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Nominees deed of charge | Creato il 09 ott 2006 Consegnato il 24 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Branch no 2022 allerton road mather avenue allerton liverpool,2047 ashford middlesex town lane stanwell staines middlesex,5105 dinnington undergate road dinnington south yorkshire (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0