TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED

TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05888955
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tesco House, Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 feb 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Simon Richard Williams come amministratore in data 25 feb 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Gibney come amministratore in data 25 feb 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 feb 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Gibney il 02 apr 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Alistair Ewan Clark il 01 apr 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 feb 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TESCO SECRETARIES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Segretario
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione08730224
    182118090001
    CLARK, Alistair Ewan, Mr.
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Treasurer160520990004
    WILLIAMS, Simon Richard
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    EnglandBritishAcquisition Director293302020001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    O'CONNOR, Claudine Elaine
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Segretario
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishAssistant Company Secretary50295880003
    PHILP, Clive James
    Oakey Lane
    SE1 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Oakey Lane
    SE1 7HN London
    25
    United Kingdom
    British140785910001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    PAILEX SECRETARIES LIMITED
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    Segretario
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    74551790001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRASHER, Richard William Peter
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector70633600002
    EADE, Graham Peter
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealandDirector153426190001
    EARP, Neil Timothy
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    Amministratore
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    BritishCompany Director83045240002
    GIBNEY, John
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    United KingdomIrishAssets And Estates Director194216530003
    HARTLEY, Johanna Ruth
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director168410960001
    HARTLEY, Johanna Ruth
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director168410960001
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58257940003
    LU, Hongyan Echo
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomChineseUk & Roi Property Director171720380001
    MAIR, Ian
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Treasurer156335170001
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    MOURANT, Nicholas Claud
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector67463160002
    O'HARE, Eamonn
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishDirector117596190001
    POTTS, David Thomas
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector61624730005
    RENNIE, James Matthew
    23 Queens Road
    HP4 3HU Berkhamstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    23 Queens Road
    HP4 3HU Berkhamstead
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor99037070001
    RIGBY, Steven Andrew
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    United KingdomBritishSurveyor161159630001
    RISK, Michael Robert
    Highcroft
    Kelshall Street
    SG8 9SH Kelshall
    Hertfordshire
    Amministratore
    Highcroft
    Kelshall Street
    SG8 9SH Kelshall
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector70209830002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor106882210001
    WHITE, Emily
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor149676640001
    WITHAM, Mark Peter
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Hertfordshire
    BritishSurveyor128610500001
    PAILEX NOMINEES LIMITED
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    Amministratore
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    74551780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05889025
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TESCO AQUA (NOMINEE 1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assigment of rental income dated 19 march 2007 and creation
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (The 'Partnership Security Trustee')
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of amendment
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 30 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The partnership secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Allerton road store mather avenue allerton liverpool, ashford middlesex store town lane stanwell staines middlesex and dinnington store undergate road dinnington south yorkshire for details of further property charged please refer to form 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (The Partnership Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental nominees deed of charge
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 27 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mather avenue allerton liverpool t/no MS531364, town lane stanwell staines middlesex t/no SYK57772, undergate road dinnington south yorkshire and the land t/no. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (The 'Partnership Security Trustee')
    Transazioni
    • 27 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 12 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenants interest in the head lease of tesco store at western road montrose.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 12 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenants interest in the head lease of tesco store at riverside drive dundee.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest under the head lease being the tesco store at kingsway west, dundee t/n ANG45174. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest under the head lease being the tesco store at nairn road forres t/n MOR6760. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a tesco store nairn road forres t/no MOR6760. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (Partnership Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole subjects k/a tesco store western road montrose tayside t/no ANG45239. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (Partnership Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole subjects k/a tesco store kingsway west dundee county of angus t/no ANG45174. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (Partnership Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 11 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a tesco store riverside drize dundee tayside t/no ANG45238. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (Partnership Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Nominees deed of charge
    Creato il 09 ott 2006
    Consegnato il 24 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Branch no 2022 allerton road mather avenue allerton liverpool,2047 ashford middlesex town lane stanwell staines middlesex,5105 dinnington undergate road dinnington south yorkshire (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Aqua (Finco 1) Limited (the "Partnership Security Trustee") or Such Other Entityappointed as Partnership Security Trustee from T
    • Tesco Aqua (Finco 1) Limited (the "Partnership Security Trustee") or Such Other Entityime to Time as Trustees for the Benefit of the P
    • Tesco Aqua (Finco 1) Limited (the "Partnership Security Trustee") or Such Other Entityappointed as Partnership Security Trustee from Time to Time as Trustees for the Benefit of the Partnership Secured Creditors
    • Tesco Aqua (Finco 1) Limited (the "Partnership Security Trustee") or Such Other Entityartnership Secured Creditors
    Transazioni
    • 24 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0