BRANDLITE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRANDLITE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05890399
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRANDLITE LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova BRANDLITE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    59-60 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRANDLITE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BRANDLITE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagine4.71

    Bilancio annuale redatto al 28 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 lug 2012

    Stato del capitale al 31 lug 2012

    • Capitale: GBP 1.456
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF in data 31 lug 2012

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 59-60 Grosvenor Street Mayfair London W1K 3HZ England in data 26 giu 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 mag 2012

    LRESSP

    Nomina di Mr Mark Adams come amministratore in data 23 mag 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ezio Sicurella come amministratore in data 23 mag 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bruce Weir Ritchie come amministratore in data 23 mag 2012

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2012 al 29 feb 2012

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Ezio Sicurella come amministratore in data 31 gen 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brett Alexander Palos come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2011

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Jonathan Simon David Anthony Rust il 29 set 2011

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 28 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bruce Weir Ritchie il 28 giu 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Park Street Westminster London W1K 2JG England in data 27 giu 2011

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2011 al 30 apr 2011

    1 pagineAA01

    legacy

    28 pagineMG01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 10 mag 2011 al 30 set 2011

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di BRANDLITE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUST, Jonathan Simon David Anthony
    The Uplands
    AL5 2PQ Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    The Uplands
    AL5 2PQ Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    BritishCompany Secretary91991430001
    ADAMS, Mark
    Hilltop Court
    14-16 Alexandra Road
    NW8 0DR London
    16
    London
    England
    Amministratore
    Hilltop Court
    14-16 Alexandra Road
    NW8 0DR London
    16
    London
    England
    EnglandBritishDirector128037810001
    GREVILLE, Helen Mary
    141 Dawpool Road
    Cricklewood
    NW2 7LA London
    Segretario
    141 Dawpool Road
    Cricklewood
    NW2 7LA London
    British110788860001
    RAYMOND, Louise Charlotte
    11 Freelands Grove
    BR1 3LH Bromley
    Kent
    Segretario
    11 Freelands Grove
    BR1 3LH Bromley
    Kent
    BritishSales & Marketing124463060001
    VINER, Paul Lewis
    Deansway
    N2 0JF London
    24
    United Kingdom
    Segretario
    Deansway
    N2 0JF London
    24
    United Kingdom
    British117768960004
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    PALOS, Brett Alexander
    Park Street
    W1K 2JG London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Street
    W1K 2JG London
    40
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone151119360001
    RITCHIE, Bruce Weir
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    Amministratore
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    EnglandBritishDirector61895720004
    SICURELLA, Ezio
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    Amministratore
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    CanadaCanadianVice President195712270001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    BRANDLITE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 05 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 mag 2010
    Consegnato il 19 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Lancaster gate t/n's NGL868818 NGL868817 NGL795189, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Accession deed
    Creato il 13 set 2007
    Consegnato il 22 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other fund 1 security beneficiaries (or any of them) and from the company to the chargee and/or the other fund 2 security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 22 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 set 2007
    Consegnato il 22 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other fund 1 security beneficiaries (or any of them) and/or the other fund 2 security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Flat 41 forset court 140 edgware road lo. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Securitybeneficiaries (The Security Agent)
    Transazioni
    • 22 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2007
    Consegnato il 27 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 2007
    Consegnato il 18 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat 41 forset court edgeware road london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRANDLITE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 ago 2013Data di scioglimento
    28 mag 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Harold John Sorsky
    Gable House 239 Regents Park Road
    N3 3LF London
    Praticante
    Gable House 239 Regents Park Road
    N3 3LF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0