LASER HOTELS ONE LIMITED

LASER HOTELS ONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLASER HOTELS ONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05893844
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LASER HOTELS ONE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MREF HOTELS ONE LIMITED07 feb 200707 feb 2007
    MACDONALD HOTELS ONE LIMITED20 set 200620 set 2006
    BOWLFLIP LIMITED02 ago 200602 ago 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 set 2021

    8 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2019

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 set 2020

    7 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company be wound up voluntarily/joint liquidators appointed 13/09/2019
    RES13

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Cessazione della carica di Vincent Frederic Marc Vernier come amministratore in data 08 lug 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vincent Vernier come segretario in data 08 lug 2019

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Timothy Selwyn Jones come amministratore in data 13 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Edward Gray come amministratore in data 24 ott 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 058938440005 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di John Brennan come amministratore in data 04 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Michael Gallagher come amministratore in data 20 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Darren William Guy come amministratore in data 20 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Vernier il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Neal Morar come segretario in data 03 ott 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Neal Morar come amministratore in data 03 ott 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Vincent Vernier come segretario in data 06 ott 2017

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Segretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    197427310001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Segretario
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    British69033180003
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Segretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    239131680001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131530001
    EDWARDS, Nicholas William John
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish29232300002
    GRAY, Robert Edward
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Amministratore
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish147752500001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    EnglandBritish173110500001
    SIDWELL, Graham Robert
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish72844280004
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Amministratore
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    STANLEY, Graham Bryan
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish46112880007
    VERNIER, Vincent Frederic Marc
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomFrench185884890003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    02 ago 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    LASER HOTELS ONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 feb 2015
    Consegnato il 26 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 26 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2010
    Consegnato il 03 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 20 ago 2010
    Consegnato il 03 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledged and charged the existing shares and any related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 25 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 25 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trus
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselftee)
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LASER HOTELS ONE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    13 set 2019Inizio della liquidazione
    27 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0