CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05939785 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 27 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Mary Elizabeth Murray come segretario in data 25 ago 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 09 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Ward come segretario in data 13 lug 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Elizabeth Ann Ward come segretario in data 11 feb 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come segretario in data 11 feb 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park, Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 24 feb 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Mary Elizabeth | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 213028950001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| HOLLOCKS, Ian Michael | Segretario | 69 Priests Lane CM15 8HG Shenfield Essex | British | 142108250001 | ||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Segretario | Syon Park, TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | British | 72128340003 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Segretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 173144440001 | |||||||
| STEVENSON, Barry John | Segretario | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | British | 102595670001 | ||||||
| TREGONING, James Ross | Segretario | 10 Gowrie Place CR3 5ZF Caterham Surrey | British | 118953190001 | ||||||
| WARD, Elizabeth Ann | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 205461790001 | |||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Amministratore | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| CORDINER, Andrew James | Amministratore | 30 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 92229270001 | ||||||
| HODKINSON, James Clifford | Amministratore | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Amministratore | Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury 8 Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Amministratore | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Amministratore | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Amministratore | Syon Park, TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Amministratore | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Amministratore | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Amministratore | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 | |||||
| WALTON, Timothy Paul | Amministratore | Ivy House Church Row Meole Brace SY3 9EY Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 59971310002 | |||||
| MD DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Shelf 399 Limited | 06 apr 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CONTINENTAL SHELF 400 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 04 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 02 lug 2007 Consegnato il 20 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the subsidiary to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land and buildings k/a bridgemere garden world nantwich cheshire t/no SL65805,CH498502,CH450380 and CH451498 and par. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 nov 2006 Consegnato il 16 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H bridgemere garden world nantwich cheshire t/nos SL65805, CH498502, CH450380, CH451498 and part of CH326461. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0