TISSUE REGENIX GROUP LTD
Panoramica
| Nome della società | TISSUE REGENIX GROUP LTD |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05969271 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TISSUE REGENIX GROUP LTD?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Indirizzo della sede legale | Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TISSUE REGENIX GROUP PLC | 28 giu 2010 | 28 giu 2010 |
| OXECO PLC | 19 ott 2006 | 19 ott 2006 |
| OXECO TWO PLC | 17 ott 2006 | 17 ott 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 ott 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 gen 2026
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Notifica di Harwood Private Equity Vi Lp come persona con controllo significativo il 08 gen 2026 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 21 gen 2026 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||||||||||
Nomina di Ms Judith Anne Madden come amministratore in data 05 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Joseph Fitzhugh Gorman come amministratore in data 13 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Sturm come amministratore in data 13 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di George Brian Phillips come amministratore in data 09 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Shervanthi Homer Vanniasinkam come amministratore in data 08 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT10 | ||||||||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 2 pagine | RR02 | ||||||||||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 42 pagine | MAR | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 059692710006, creata il 23 dic 2025 | 67 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Miss Kirsten Mary Lund come amministratore in data 17 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Ray Lee come amministratore in data 15 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Jay Charles Lecoque come amministratore in data 04 set 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Trevor Michael Phillips come amministratore in data 05 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Martin Glenn come amministratore in data 05 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di David Claiborne Cocke come amministratore in data 31 lug 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024 | 85 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 giu 2024
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUND, Kirsten Mary | Segretario | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | 265561660001 | |||||||
| GORMAN, Geoffrey Joseph Fitzhugh | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 344465820001 | |||||
| LECOQUE, Jay Charles | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 340092570001 | |||||
| LUND, Kirsten Mary | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 341789650001 | |||||
| MADDEN, Judith Anne | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 344488970001 | |||||
| STURM, Timothy James | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 142871130003 | |||||
| BARKER, Michael Denis | Segretario | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 219336440001 | |||||||
| BELOW, Paul | Segretario | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 242703280001 | |||||||
| BRETHERTON, Michael Anthony | Segretario | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | 152329670001 | |||||||
| DEVLIN, Paul | Segretario | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 221870670001 | |||||||
| GORDON, Nigel Raymond | Segretario | 22 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | British | 34955700003 | ||||||
| JEFFERSON, Ian David | Segretario | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | British | 160870460001 | ||||||
| JONES, Gareth Hywel | Segretario | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 252392970001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| AUBREY, Alan John | Amministratore | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 77053350002 | |||||
| BARKER, Michael Denis | Amministratore | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 160393640002 | |||||
| BRETHERTON, Michael Anthony | Amministratore | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 114056040001 | |||||
| COCKE, David Claiborne | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 279282120001 | |||||
| COULDWELL, Steven | Amministratore | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 180689210001 | |||||
| DAVIES, Stephen Graham, Professor | Amministratore | Wellington Square OX1 2JD Oxford University Offices Oxfordshire | United Kingdom | British | 136712640001 | |||||
| DEVLIN, Paul John | Amministratore | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 113889280002 | |||||
| FIELDING, Alison Margaret, Dr | Amministratore | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 97075620002 | |||||
| GLENN, Jonathan Martin | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United Kingdom | British | 148251560003 | |||||
| GORDON, Nigel Raymond | Amministratore | 22 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 34955700003 | |||||
| GREWAL, Randeep Singh | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 180652980001 | |||||
| HALL, Gordon James | Amministratore | Aberkirk House Dumblehole Lane Ashford Carbonel SY8 4DF Ludlow Shropshire | England | British | 56289410002 | |||||
| HOMER VANNIASINKAM, Shervanthi, Professor | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 208704030001 | |||||
| JEFFERSON, Ian David | Amministratore | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 80245080002 | |||||
| JONES, Gareth Hywel | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United Kingdom | British | 59032980002 | |||||
| LEE, Daniel Ray | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 277099400001 | |||||
| MILLER, Alan Jonathan Richard | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 127433380001 | |||||
| NORWOOD, David Robert | Amministratore | 53 St John's Street OX1 2LQ Oxford | British | 83359010002 | ||||||
| ODELL, Antony Ruben | Amministratore | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 152306920001 | |||||
| PHILLIPS, George Brian | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 118807400001 | |||||
| PHILLIPS, Trevor Michael | Amministratore | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 199317050002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harwood Private Equity Vi Lp | 08 gen 2026 | Stratton Street W1J 8LD London 6 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Invesco Limited | 24 lug 2017 | Perpetual Park Drive RG9 1HH Henley On Thames Perpetual Park Oxfordshire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Woodford Investment Management Ltd | 24 lug 2017 | Garsington Road OX4 2HN Oxford 9400 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 12 nov 2019 | 08 gen 2026 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0