USE (WATFORD) LIMITED

USE (WATFORD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUSE (WATFORD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05969853
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di USE (WATFORD) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova USE (WATFORD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di USE (WATFORD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    USE (WOKINGHAM) LIMITED17 ott 200617 ott 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di USE (WATFORD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per USE (WATFORD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 nov 2020

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 nov 2019

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 nov 2018

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ a 82 st John Street London EC1M 4JN in data 07 ago 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    2 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 nov 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    9 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 06 mar 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2014

    Stato del capitale al 03 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 nov 2013

    Stato del capitale al 06 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 16 set 2013

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di USE (WATFORD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish151895310001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione6133267
    123430390001
    DUNCAN, David Walter
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    Segretario
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    British115440520001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BIRCH, Trevor Nigel
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    Amministratore
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    United KingdomBritish136579440001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Amministratore
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    DUNCAN, David Walter
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    Amministratore
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    British115440520001
    EWLES, Laura Jane
    100 Finsbury Park Road
    N4 2JT London
    Greater London
    Amministratore
    100 Finsbury Park Road
    N4 2JT London
    Greater London
    British119694120001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David Anthony
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Amministratore
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Holly Mount Lane Tottington
    BL8 4HP Bury
    Amministratore
    The Long Barn
    Holly Mount Lane Tottington
    BL8 4HP Bury
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Amministratore
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    TANDY, Didier Michel
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001

    USE (WATFORD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 25 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Arliss court, 24 clarendon road, watford, t/no: HD158049 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Refinancing Fee Beneficiary
    Transazioni
    • 25 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 25 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Arliss court, 24 clarendon road, watford, t/no: HD158049 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 25 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 23 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 23 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Arliss court 24 clarendon road watford t/n HD158049. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    USE (WATFORD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 nov 2015Inizio della liquidazione
    09 dic 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praticante
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praticante
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0