BRANDSPACE GROUP LIMITED

BRANDSPACE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRANDSPACE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05973040
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PROMOTION SPACE GROUP LIMITED24 apr 200724 apr 2007
    COBCO 810 LIMITED20 ott 200620 ott 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2018

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2017

    11 pagine4.68

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Jane Elizabeth Vinson come amministratore in data 28 set 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sebastien Canderle come amministratore in data 02 giu 2016

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2016

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2015

    13 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 mar 2014

    14 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 ott 2013

    14 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    31 pagine2.17B

    Chi sono gli amministratori di BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Segretario
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Segretario
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ALLNER, Christopher Charles
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    Amministratore
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    EnglandBritish78206300001
    BERGIN, Joseph Damien
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish113935400001
    CANDERLE, Sebastien
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandFrench124282690001
    FAY, Sean Ernan
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    Amministratore
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    United KingdomIrish84925400001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish56356980006
    JONES, Neil Henry
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    United KingdomBritish139632430001
    KEILLER, Andrew James
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    Amministratore
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    United KingdomBritish172132420001
    LANE, Damien John Patrick
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    EnglandEnglish158036110001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    RAVILIOUS, Greg William Frederick
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    Amministratore
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    United KingdomBritish130854210001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    Amministratore
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Amministratore
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SPOONER, Julian Robert Archer
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    Amministratore
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    EnglandBritish117770880001
    TAYLOR, Richard David
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish123754500001
    VINSON, Jane Elizabeth
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish146632890001
    WADE, Roy
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    Amministratore
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    British131852890001
    WRIGHT, Richard Alan
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    Amministratore
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    United KingdomBritish80470950001
    COBBETTS (DIRECTOR) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Amministratore
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    107196800001

    BRANDSPACE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 nov 2009
    Consegnato il 13 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 14 lug 2009
    Consegnato il 31 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited
    Transazioni
    • 31 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of a life policy
    Creato il 12 ago 2008
    Consegnato il 14 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    P/No L0198163613, argon scottish equitable, life cover £500,000, date 31/07/08, life assured paul soanes see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Life assured stephan hughes zurich assurance limited policy number 1827-62L-dhs lifestyle benefit: £1,000,000 life cover: £2,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Life assured guy soar zurich assurance limited policy number 1845-62L-dhs lifestyle benefit: £500,000 life cover: £1,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2008
    Debenture
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of policy
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy being dated 1 july 2007 p/no 1845-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of guy jason soar in the sum of £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of policy
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy dated 1 july 2007 p/no 1827-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of stephen michael hughes in the sum of £2,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    BRANDSPACE GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 apr 2013Inizio dell'amministrazione
    28 mar 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DataTipo
    28 mar 2014Inizio della liquidazione
    16 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidatore proposto
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidatore proposto
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0