OPAL ST GEORGES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | OPAL ST GEORGES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05976208 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OPAL ST GEORGES LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova OPAL ST GEORGES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OPAL ST GEORGES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OPAL GREENWICH LIMITED | 24 ott 2006 | 24 ott 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OPAL ST GEORGES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per OPAL ST GEORGES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2019 | 6 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2018 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2017 | 4 pagine | 4.68 | ||||||||||
Domanda di insolvenza Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Place Ducie Street Manchester M1 2TP a 15 Canada Square London E14 5GL in data 18 feb 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Jones Day 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2013 | 19 pagine | AR01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Jones Day 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 20 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2014 | 20 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 47 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brett Alan Lashley come amministratore in data 04 giu 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard James Spencer come amministratore in data 04 giu 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Brett Alan Lashley come amministratore in data 25 feb 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig Allan Mellor come segretario in data 25 feb 2015 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Barrie Wall come amministratore in data 25 feb 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig Allan Mellor come amministratore in data 25 feb 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Robert Duncan come amministratore in data 25 feb 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a The Place Ducie Street Manchester M1 2TP in data 06 mar 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OPAL ST GEORGES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER, Richard James | Amministratore | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | United Kingdom | British | Real Estate Investor | 190526870001 | ||||
| MELLOR, Craig Allan | Segretario | 21 Queenston Road Didsbury M20 2NX Manchester | British | 60906780002 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900015000001 | |||||||
| DUNCAN, Gavin Robert | Amministratore | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | Director | 151512820001 | ||||
| LASHLEY, Brett Alan | Amministratore | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | United States Of America | Director Real Estate Investment | 196201790001 | ||||
| MELLOR, Craig Allan | Amministratore | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | Director | 60906780002 | ||||
| SMITH, David Ryder | Amministratore | 5 Acacia Avenue WA15 8QX Hale Cheshire | England | British | Company Director | 202067380001 | ||||
| WALL, Stuart Barrie | Amministratore | Old Acres Well Bank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 95010340001 | ||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
OPAL ST GEORGES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Creato il 04 apr 2012 Consegnato il 19 apr 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Debenture | Creato il 15 set 2008 Consegnato il 24 set 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 set 2007 Consegnato il 26 set 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings at st georges close netherthorpe sheffield and land and buildings on the west side of beet street sheffield t/no SYK495558 and SYK531664. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
OPAL ST GEORGES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ricevitore/gestore nominato |
| |||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0