KHL 2017 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKHL 2017 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05980135
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KHL 2017 LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova KHL 2017 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp 5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KHL 2017 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KIMBERLY HOLDINGS LIMITED19 dic 200719 dic 2007
    ENSCO 543 LIMITED27 ott 200627 ott 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di KHL 2017 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per KHL 2017 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2023

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 08 feb 2022

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ England a C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp 5th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 14 feb 2022

    2 pagineAD01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    18 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2018

    20 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name18 lug 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 lug 2017

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da 13 Hornbeam Square South Harrogate North Yorkshire HG2 8NB a One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ in data 17 lug 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2016

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2015

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KHL 2017 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Eric
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Segretario
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    British133606820001
    FOSTER, David Eric
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Amministratore
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    EnglandBritish133606820002
    HARRISON, Steven Richard
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Amministratore
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    EnglandBritish135203380001
    UNSWORTH, Geraldine Louise
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Amministratore
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    United KingdomBritish123347740001
    MAYLAND, Ian David
    Richmond Avenue
    Sneyd Green
    ST1 6DH Stoke-On-Trent
    10
    Staffordshire
    Segretario
    Richmond Avenue
    Sneyd Green
    ST1 6DH Stoke-On-Trent
    10
    Staffordshire
    British132466550001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Segretario
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British103609160001
    UNSWORTH, Geraldine Louise
    60 Skyes Crescent
    Winstanley
    WN3 6HU Wigan
    Lancashire
    Segretario
    60 Skyes Crescent
    Winstanley
    WN3 6HU Wigan
    Lancashire
    British123347740001
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    FIGGINS, Paul
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    1
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    1
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish146403620001
    HARTIS, Keith
    Burnhill Court
    Standish
    WN17 3UD Wigan
    11
    Amministratore
    Burnhill Court
    Standish
    WN17 3UD Wigan
    11
    EnglandBritish148679490001
    LEDGER, Raymond
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    13
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    13
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish123347680002
    LYNDON, Andrew Steven
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    13
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Square South
    HG2 8NB Harrogate
    13
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish83859060003
    MAYLAND, Ian David
    Richmond Avenue
    Sneyd Green
    ST1 6DH Stoke-On-Trent
    10
    Staffordshire
    Amministratore
    Richmond Avenue
    Sneyd Green
    ST1 6DH Stoke-On-Trent
    10
    Staffordshire
    EnglandBritish132466550001
    MCNAMARA, Steve
    Messingham
    DN17 3UD Scunthorpe
    The Meadows
    North Lincolnshire
    Amministratore
    Messingham
    DN17 3UD Scunthorpe
    The Meadows
    North Lincolnshire
    United KingdomBritish133349650001
    PERRY, Jim
    Thornly Park Drive
    PA2 7RR Paisley
    14
    Renfrewshire
    Amministratore
    Thornly Park Drive
    PA2 7RR Paisley
    14
    Renfrewshire
    United KingdomBritish139882180001
    PIEKARUS, Peter
    117 Church Road
    Bickerstaffe
    L39 0EB Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    117 Church Road
    Bickerstaffe
    L39 0EB Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritish123351520001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish103609160001
    HBJGW INCORPORATIONS LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    68279000005

    Chi sono le persone con controllo significativo di KHL 2017 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    England
    06 apr 2016
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02495714
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr David Eric Foster
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    06 apr 2016
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Ms Geraldine Louise Unsworth
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    06 apr 2016
    5th Floor, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    KHL 2017 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 lug 2011
    Consegnato il 23 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2011
    Consegnato il 04 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 06 mag 2010
    Consegnato il 12 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited ("Security Trustee")
    Transazioni
    • 12 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 24 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the loan notes from time to time on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of amendment
    Creato il 30 giu 2009
    Consegnato il 11 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and its successors in title as security trustee for the holders of the loan notes from time to time on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 11 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    KHL 2017 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 feb 2022Inizio della liquidazione
    20 dic 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Miller
    5th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    5th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Gareth Harris
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0