CASTLE TOPCO LIMITED

CASTLE TOPCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLE TOPCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05988581
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLE TOPCO LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova CASTLE TOPCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLE TOPCO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CREST NICHOLSON GROUP LIMITED19 giu 200719 giu 2007
    CASTLE TOPCO LIMITED03 nov 200603 nov 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE TOPCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE TOPCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ripristino per ordine del tribunale

    2 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * Crest House Pyrcroft Road Chertsey Surrey KT16 9GN* in data 04 ott 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 set 2011

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 ott 2010

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Stone il 09 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Stone il 09 feb 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di David Darby come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2010

    Stato del capitale al 03 nov 2010

    • Capitale: GBP 10,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2009

    9 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Kevin Maguire il 14 dic 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio consolidato redatto al 31 ott 2008

    38 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di CASTLE TOPCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAGUIRE, Kevin
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    United Kingdom
    Other134492090001
    STONE, Stephen
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish44699490003
    TINKER, Nigel Christopher
    344 Wokingham Road
    Earley
    RG6 7DE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    344 Wokingham Road
    Earley
    RG6 7DE Reading
    Berkshire
    British59485480002
    HAGUE, William George
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    Segretario
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    British47127600003
    HUGHES, Nigel Ian
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    Segretario
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    British66545910004
    JONES, Mark Roger
    Lower Mead
    GU31 4NR Petersfield
    61
    Hants
    Segretario
    Lower Mead
    GU31 4NR Petersfield
    61
    Hants
    Other134467410001
    SEALES, Sharon
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    Segretario
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    British106673560001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Amministratore
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    CALLCUTT, Paul
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9HN Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9HN Chertsey
    Surrey
    British45232370004
    DARBY, David Peter
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Crest House
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Surrey
    British75556860004
    DAVIDSON, Paul Richmond
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    Amministratore
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    British116631880001
    DAVIES, Philip James
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    Amministratore
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    EnglandBritish115123570001
    HEPBURN, Alastair John Harley
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish114477450001
    MCMAHON, Jim Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Amministratore
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    EnglandBritish116631870001
    MCMILLAN, Gary
    13 Station Road
    Buzby
    G76 8HX Glasgow
    Amministratore
    13 Station Road
    Buzby
    G76 8HX Glasgow
    British116631860001
    MORAN, John Conway
    20 Woodend Drive
    G13 1QS Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    20 Woodend Drive
    G13 1QS Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish104387940001
    MUMFORD, Joanna
    25 Hugh Miller Place
    EH3 5JG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    25 Hugh Miller Place
    EH3 5JG Edinburgh
    Midlothian
    British117235700002
    SHEARER, David James Buchanan
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    Amministratore
    Pyrcroft Road
    KT16 9GN Chertsey
    Crest House
    Surrey
    British127586270002

    CASTLE TOPCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 mar 2007
    Consegnato il 20 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Securitybeneficiaries (the Security Agent)
    Transazioni
    • 20 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CASTLE TOPCO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 set 2011Inizio della liquidazione
    30 ago 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0