UNITE LIVING LIMITED

UNITE LIVING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNITE LIVING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05994762
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNITE LIVING LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova UNITE LIVING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Core
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNITE LIVING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LDC (CROWN HOUSE) LIMITED10 nov 200610 nov 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNITE LIVING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per UNITE LIVING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr David Faulkner come amministratore in data 27 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Guy Richards come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Christopher Allan come amministratore in data 20 mag 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 dic 2015

    Stato del capitale al 07 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Julian Lister il 27 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 23 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 02 gen 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 nov 2014

    Stato del capitale al 17 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ldc (crown house) LIMITED\certificate issued on 16/12/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name16 dic 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 dic 2013

    RES15
    change-of-name16 dic 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2013

    Stato del capitale al 25 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Reid come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di UNITE LIVING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Segretario
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    British175753180001
    FAULKNER, David
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    United KingdomBritish219353910001
    LISTER, Joseph Julian
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    United KingdomBritish124180960001
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    United KingdomBritish175753180001
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Segretario
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    British67884910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLAN, Mark Christopher
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    EnglandBritish74371010007
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Amministratore
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritish86546430001
    GRANGER, James Winston Edward
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    Amministratore
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    EnglandBritish119802100001
    GRANT, Stephen Richard
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish146103670002
    HULL, Jonathan
    Old Post Office
    Boxford
    RG20 8DH Newbury
    West Berkshire
    Amministratore
    Old Post Office
    Boxford
    RG20 8DH Newbury
    West Berkshire
    EnglandBritish116761670001
    MCDONALD, David Andrew
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    Amministratore
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    EnglandBritish67201010001
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Amministratore
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    United KingdomBritish67884910002
    RICHARDS, Nicholas Guy
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    EnglandBritish122256380002

    UNITE LIVING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 lug 2007
    Consegnato il 24 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 18 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H crown house reading t/no bk 43782.
    Persone aventi diritto
    • T a Fisher Developments Limited
    Transazioni
    • 18 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 18 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a crown house, 2-10 crown street, 130-134 london street, reading t/no BK43782 and including all buildings, erections, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings but excluding, in case of l/h property, landlord's fixtures). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0