UNITE LIVING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | UNITE LIVING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05994762 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UNITE LIVING LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova UNITE LIVING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Core 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UNITE LIVING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LDC (CROWN HOUSE) LIMITED | 10 nov 2006 | 10 nov 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UNITE LIVING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per UNITE LIVING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Nomina di Mr David Faulkner come amministratore in data 27 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Guy Richards come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Christopher Allan come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Julian Lister il 27 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 23 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 02 gen 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed ldc (crown house) LIMITED\certificate issued on 16/12/13 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di UNITE LIVING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Segretario | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | British | 175753180001 | ||||||
| FAULKNER, David | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 219353910001 | |||||
| LISTER, Joseph Julian | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 124180960001 | |||||
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 175753180001 | |||||
| REID, Andrew Donald | Segretario | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | 67884910002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLAN, Mark Christopher | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | England | British | 74371010007 | |||||
| BENNETT, Michael Peter | Amministratore | 45 Drakes Way Portishead BS20 6LD Bristol | England | British | 86546430001 | |||||
| GRANGER, James Winston Edward | Amministratore | Southdale 48 Greenway Lane BA2 4LW Bath | England | British | 119802100001 | |||||
| GRANT, Stephen Richard | Amministratore | Alma Road Clifton BS8 2BY Bristol 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 146103670002 | |||||
| HULL, Jonathan | Amministratore | Old Post Office Boxford RG20 8DH Newbury West Berkshire | England | British | 116761670001 | |||||
| MCDONALD, David Andrew | Amministratore | Cherith Church Lane Chew Stoke BS40 8TU Bristol Avon | England | British | 67201010001 | |||||
| REID, Andrew Donald | Amministratore | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | United Kingdom | British | 67884910002 | |||||
| RICHARDS, Nicholas Guy | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | England | British | 122256380002 |
UNITE LIVING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 16 lug 2007 Consegnato il 24 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 gen 2007 Consegnato il 18 gen 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H crown house reading t/no bk 43782. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 gen 2007 Consegnato il 18 gen 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a crown house, 2-10 crown street, 130-134 london street, reading t/no BK43782 and including all buildings, erections, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings but excluding, in case of l/h property, landlord's fixtures). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0