MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05996964 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Walkmill Lane Cannock WS11 0XA Staffordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2017 al 29 mar 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Xia Kong come amministratore in data 28 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Xia Kong come amministratore in data 17 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fabrice Deriaz come amministratore in data 17 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jerry Ren come amministratore in data 17 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jason Coleman come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason Coleman come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Fabrice Deriaz come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Barrick come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REN, Jerry | Amministratore | Walkmill Lane Cannock WS11 0XA Staffordshire | Australia | Chinese | 113020880007 | |||||
| BLACKMORE, John | Segretario | 5 Squirrels Corner Newborough DE13 8SA Burton On Trent Staffordshire | British | 62986970001 | ||||||
| COLEMAN, Jason Mark | Segretario | High Street Austerfield DN10 6QT Doncaster C/O Bawtry Investments Limited South Yorkshire United Kingdom | 168633620001 | |||||||
| JAYASEKERA, Rajni | Segretario | Flat 10 Lords View One St Johns Wood Road NW8 7HJ London | British | 116819780001 | ||||||
| LEE, Young Jin | Segretario | 28 Marlborough Street, Unit 1 Boston Massachusetts Ma 02116 Usa | American | 117202540001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Segretario | Walkmill Lane Cannock WS11 0XA Staffordshire | 154423410001 | |||||||
| BANKES JONES, Henry | Amministratore | The Old Rose Littlebury Green CB11 4XB Saffron Waldon Cambridge Essex Cb11 4xb | British | 116570350001 | ||||||
| BARRICK, Richard Frank | Amministratore | High Street Austerfield DN10 6QT Doncaster C/O Bawtry Investments Limited South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78742910001 | |||||
| COLEMAN, Jason Mark | Amministratore | High Street Austerfield DN10 6QT Doncaster C/O Bawtry Investments Limited South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 69435470002 | |||||
| DENT, Andrew Jonathan | Amministratore | 1 Chestnut Close Handsacre WS15 4TH Rugeley Staffordshire | British | 32327170001 | ||||||
| DERIAZ, Fabrice | Amministratore | Walkmill Lane WS11 0XA Cannock C/O Nicholl Food Packaging Limited Staffordshire United Kingdom | Switzerland | Swiss | 176918870001 | |||||
| EWALD, Oliver Christian | Amministratore | Two Avery St Apt 18c MA 02111 Boston | Usa | German | 102179380001 | |||||
| GRIFFITHS, Emrys John | Amministratore | Bamford Mill The Hollow Bamford S33 0AU Hope Valley 4 Musgrave House Derbyshire | England | British | 154423550002 | |||||
| JONES-PERCIVAL, David | Amministratore | St Leonards View Home Farm Barns DY12 2TQ Ribbesford Worcestershire | England | British | 177806180001 | |||||
| KONG, Xia | Amministratore | Walkmill Lane Cannock WS11 0XA Staffordshire | Australia | Chinese | 193176190001 | |||||
| LEE, Young Jin | Amministratore | 28 Marlborough Street, Unit 1 Boston Massachusetts Ma 02116 Usa | American | 117202540001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Amministratore | Station Road CV13 0NP Market Bosworth Spinney Cottage Warwickshire | England | British | 154423590001 | |||||
| SHARPE, Clive Richard | Amministratore | Knighton Rise LE2 2RE Leicester 18 Leics | England | British | 134995270001 | |||||
| SPEIRS, William Blake, Professor | Amministratore | Calver S32 3WW Sheffield The Cornmill South Yorkshire | England | British | 13196350001 | |||||
| WEINTRAUB, Daniel Harris | Amministratore | 46, Cedar Lane Way Boston Massachusetts Ma 02108-1214 Usa | American | 117202710001 | ||||||
| PROTURN LIMITED | Amministratore | Rutland Park S10 2PD Sheffield 2 South Yorkshire | 138773850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packco Limited | 06 apr 2016 | Wyrley Brook Retail Park, Walkmill Lane WS11 0XA Cannock Nicholl Food Packaging England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 21 mag 2012 Consegnato il 26 mag 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Hedging agreement assignment | Creato il 25 mar 2011 Consegnato il 31 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title and interest in respect of the hedging agreements see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Key-man policies assignment | Creato il 12 feb 2010 Consegnato il 20 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The policies being william blake speirs p/no 3405622ET. Simon george paul p/no 3405625EG and emrys griffiths p/no 3405621EE. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 nov 2008 Consegnato il 06 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 nov 2006 Consegnato il 07 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0