MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED

MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARCELL ACQUISITIONCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05996964
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2017 al 29 mar 2017

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Xia Kong come amministratore in data 28 ago 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2016

    Stato del capitale al 08 gen 2016

    • Capitale: GBP 194,140
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2015

    Stato del capitale al 13 gen 2015

    • Capitale: GBP 194,140
    SH01

    Nomina di Xia Kong come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fabrice Deriaz come amministratore in data 17 nov 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jerry Ren come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 gen 2014

    Stato del capitale al 24 gen 2014

    • Capitale: GBP 194,140
    SH01

    Cessazione della carica di Jason Coleman come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jason Coleman come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Fabrice Deriaz come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Barrick come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REN, Jerry
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    Amministratore
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    AustraliaChinese113020880007
    BLACKMORE, John
    5 Squirrels Corner
    Newborough
    DE13 8SA Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    5 Squirrels Corner
    Newborough
    DE13 8SA Burton On Trent
    Staffordshire
    British62986970001
    COLEMAN, Jason Mark
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    168633620001
    JAYASEKERA, Rajni
    Flat 10 Lords View One
    St Johns Wood Road
    NW8 7HJ London
    Segretario
    Flat 10 Lords View One
    St Johns Wood Road
    NW8 7HJ London
    British116819780001
    LEE, Young Jin
    28 Marlborough Street,
    Unit 1
    Boston
    Massachusetts Ma 02116
    Usa
    Segretario
    28 Marlborough Street,
    Unit 1
    Boston
    Massachusetts Ma 02116
    Usa
    American117202540001
    PAUL, Simon George
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    Segretario
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    154423410001
    BANKES JONES, Henry
    The Old Rose
    Littlebury Green
    CB11 4XB Saffron Waldon Cambridge
    Essex
    Cb11 4xb
    Amministratore
    The Old Rose
    Littlebury Green
    CB11 4XB Saffron Waldon Cambridge
    Essex
    Cb11 4xb
    British116570350001
    BARRICK, Richard Frank
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78742910001
    COLEMAN, Jason Mark
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Austerfield
    DN10 6QT Doncaster
    C/O Bawtry Investments Limited
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69435470002
    DENT, Andrew Jonathan
    1 Chestnut Close
    Handsacre
    WS15 4TH Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Chestnut Close
    Handsacre
    WS15 4TH Rugeley
    Staffordshire
    British32327170001
    DERIAZ, Fabrice
    Walkmill Lane
    WS11 0XA Cannock
    C/O Nicholl Food Packaging Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Walkmill Lane
    WS11 0XA Cannock
    C/O Nicholl Food Packaging Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    SwitzerlandSwiss176918870001
    EWALD, Oliver Christian
    Two Avery St
    Apt 18c
    MA 02111 Boston
    Amministratore
    Two Avery St
    Apt 18c
    MA 02111 Boston
    UsaGerman102179380001
    GRIFFITHS, Emrys John
    Bamford Mill
    The Hollow Bamford
    S33 0AU Hope Valley
    4 Musgrave House
    Derbyshire
    Amministratore
    Bamford Mill
    The Hollow Bamford
    S33 0AU Hope Valley
    4 Musgrave House
    Derbyshire
    EnglandBritish154423550002
    JONES-PERCIVAL, David
    St Leonards View
    Home Farm Barns
    DY12 2TQ Ribbesford
    Worcestershire
    Amministratore
    St Leonards View
    Home Farm Barns
    DY12 2TQ Ribbesford
    Worcestershire
    EnglandBritish177806180001
    KONG, Xia
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    Amministratore
    Walkmill Lane
    Cannock
    WS11 0XA Staffordshire
    AustraliaChinese193176190001
    LEE, Young Jin
    28 Marlborough Street,
    Unit 1
    Boston
    Massachusetts Ma 02116
    Usa
    Amministratore
    28 Marlborough Street,
    Unit 1
    Boston
    Massachusetts Ma 02116
    Usa
    American117202540001
    PAUL, Simon George
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Spinney Cottage
    Warwickshire
    Amministratore
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Spinney Cottage
    Warwickshire
    EnglandBritish154423590001
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Amministratore
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    SPEIRS, William Blake, Professor
    Calver
    S32 3WW Sheffield
    The Cornmill
    South Yorkshire
    Amministratore
    Calver
    S32 3WW Sheffield
    The Cornmill
    South Yorkshire
    EnglandBritish13196350001
    WEINTRAUB, Daniel Harris
    46, Cedar Lane Way
    Boston
    Massachusetts Ma 02108-1214
    Usa
    Amministratore
    46, Cedar Lane Way
    Boston
    Massachusetts Ma 02108-1214
    Usa
    American117202710001
    PROTURN LIMITED
    Rutland Park
    S10 2PD Sheffield
    2
    South Yorkshire
    Amministratore
    Rutland Park
    S10 2PD Sheffield
    2
    South Yorkshire
    138773850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wyrley Brook Retail Park, Walkmill Lane
    WS11 0XA Cannock
    Nicholl Food Packaging
    England
    06 apr 2016
    Wyrley Brook Retail Park, Walkmill Lane
    WS11 0XA Cannock
    Nicholl Food Packaging
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompany Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06747727
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MARCELL ACQUISITIONCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 mag 2012
    Consegnato il 26 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Hedging agreement assignment
    Creato il 25 mar 2011
    Consegnato il 31 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in respect of the hedging agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Key-man policies assignment
    Creato il 12 feb 2010
    Consegnato il 20 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policies being william blake speirs p/no 3405622ET. Simon george paul p/no 3405625EG and emrys griffiths p/no 3405621EE. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2008
    Consegnato il 06 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0