PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06021111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di servizi di informazione n.c.a. (63990) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6 More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVER KITE TWO LIMITED06 dic 200606 dic 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Verman il 24 nov 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Martin Verman come amministratore in data 03 mar 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeffrey Scott Krentz come amministratore in data 03 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Walter Patanella come amministratore in data 03 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Olivier Lefranc come amministratore in data 03 mar 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Broadgate London EC2M 2QS a 6 More London Place Tooley Street London SE1 2QY in data 07 dic 2020

    1 pagineAD01

    Notifica di Tns Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 05 dic 2019

    1 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 27 nov 2020

    2 paginePSC09

    Cessazione della carica di Andrew James Brown come amministratore in data 21 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marie Guilhot-Gaudeffroy come amministratore in data 25 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Wpp Group (Nominees) Limited come segretario in data 24 mar 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 dic 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Cessazione di Wpp Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 05 dic 2019

    1 paginePSC07

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RICHARDSON, Giles Harvey Roberts
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    Amministratore
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    EnglandBritish224284590001
    VERMAN, Martin
    6 More London Place
    SE1 2QY London
    6 More London Place
    England
    Amministratore
    6 More London Place
    SE1 2QY London
    6 More London Place
    England
    EnglandBritish264708520002
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    British147777590001
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Segretario
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    165480680001
    LOW, Peter
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    148750770001
    LOW, Peter
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    Segretario
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    British65476890001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Segretario
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    British141063520001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Segretario
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06021111
    198012820001
    BROWN, Andrew James
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    United KingdomBritish76673960002
    FAWCUS, Keir Murray
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish84594470003
    GREGSON, David John
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish75087330007
    GUILHOT-GAUDEFFROY, Marie
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    FranceFrench197413690001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Amministratore
    The Registry
    3 Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    United KingdomBritish147777590001
    HAWORTH, John Roger
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish91354480002
    HILLIARD, Charles Stephen
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    Amministratore
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    British104848990001
    HOLROYD, Martin
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    United KingdomBritish116530590001
    KECK, Kevin
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    United KingdomAmerican85035000001
    KRENTZ, Jeffrey Scott
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    Amministratore
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    U.KAmerican109891750002
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish88368490002
    LEFRANC, Olivier
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    Amministratore
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    FranceFrench194050460001
    LOW, Peter
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish65476890002
    MAN, David Pui Kee
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish197151080001
    PATANELLA, Walter
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    Amministratore
    More London Place
    Tooley Street
    SE1 2QY London
    6
    England
    FranceItalian178947960001
    PRIME, Anthony Robert
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish80022490001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Amministratore
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    EnglandBritish141063520001
    THOMAS, James Robert
    Lea Farm
    Gate Street
    GU5 0LR Bramley
    Surrey
    Amministratore
    Lea Farm
    Gate Street
    GU5 0LR Bramley
    Surrey
    United KingdomBritish86644110001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    60471930010

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tns Group Holdings Limited
    More London Place
    SE1 2QY London
    6
    England
    05 dic 2019
    More London Place
    SE1 2QY London
    6
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    06 dic 2016
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02670617
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    21 feb 202027 nov 2020La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PRECISE MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 feb 2014
    Consegnato il 01 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Insurance assignment (of keyman life policies)
    Creato il 13 feb 2007
    Consegnato il 01 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Nsurer: bassett life. Life assured: peter low. Policy number: 20575. sum assured: £500,000. term: life/critical ilness cover. Commencement date: 13 december 2006. insurer: bassett life. Life assured: keir fawcus. Policy number: 20571. sum assured: £500,000. term: life/critical ilness cover. Commencement date: 13 december 2006. insurer: bassett life. Life assured: charles hilliard. Policy number: 20570. sum assured: £500,000. term: life/critical ilness cover. Commencement date: 13 december 2006 and all security interests and dispositions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties) the Security Agent
    Transazioni
    • 01 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over cash deposit
    Creato il 15 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being all sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the account, sort code 15-10-00 account number 22438827. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Charles Stephen Hilliard, Peter Low, John Shepherd, Peter Harkness, Keir Fawcus, Anthony Prime,Stephen Dolton (The 'D Loan Note Holders', Eacha 'D Loan Note Holder')
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2006
    Consegnato il 20 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 20 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0