CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 06067297 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Prince Albert House 2 Kingsmill Terrace NW8 6BN London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SCREENPRINT DONCASTER HOLDINGS LIMITED | 28 mar 2007 | 28 mar 2007 |
L&P 174 LIMITED | 25 gen 2007 | 25 gen 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 21 dic 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Gray's Inn Secretaries Limited il 09 gen 2013 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 21 dic 2012 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2012 al 21 dic 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed screenprint doncaster holdings LIMITED\certificate issued on 29/01/13 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mohamed Dirhem Abdo Saeed il 10 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Gray's Inn Secretaries Limited come segretario in data 09 gen 2013 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Margetts come segretario in data 21 dic 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | pagine | MG01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Quadrant 4 Yorkshire Way Armthorpe Doncaster South Yorkshire DN3 3FB in data 07 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2013 al 31 dic 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Margetts come amministratore in data 21 dic 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Anthony Walton come amministratore in data 21 dic 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Roderick Charles Ainslie come amministratore in data 21 dic 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Richard Bradburn come amministratore in data 21 dic 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mohamed Dirhem Abdo Saeed come amministratore in data 21 dic 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 16 pagine | MG01 | ||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED | Segretario | - EC4M 7WS London One Fleet Place England |
| 174868400001 | ||||||||||
AINSLIE, Roderick Charles | Amministratore | Glen Road FK15 0DJ Dunblane Glen Holme Perthshire Scotland | United Kingdom | British | Managing Director | 43273080002 | ||||||||
BRADBURN, Timothy Richard | Amministratore | Main Street Whittington WS14 9JU Lichfield 1 Staffordshire England | England | British | Accountant | 105361400001 | ||||||||
SAEED, Mohamed Dirhem Abdo | Amministratore | Prince Albert House 2 Kingsmill Terrace NW8 6BN London Longulf Trading (Uk) Ltd England | England | British | Deputy Managing Director | 174741350002 | ||||||||
WALTON, Richard Anthony | Amministratore | Meadows Road Manvers S63 5DJ Rotherham Brookfields Park South Yorkshire England | England | British | Operations Director | 174741180001 | ||||||||
MARGETTS, Sandra | Segretario | 2 Kingsmill Terrace NW8 6BN London Prince Albert House England | British | Director | 94395470001 | |||||||||
LEE & PRIESTLEY SECRETARY LIMITED | Segretario | 10-12 East Parade LS1 2AJ Leeds West Yorkshire | 90359580001 | |||||||||||
BRINDLE, Robert Alan | Amministratore | 2 Valley Avenue South Elmsall WF9 2DE Pontefract West Yorkshire | British | Director | 116733780001 | |||||||||
MARGETTS, Sandra | Amministratore | Yorkshire Way Armthorpe DN3 3FB Doncaster Quadrant 4 South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 94395470001 | ||||||||
LEE & PRIESTLEY LIMITED | Amministratore | 10-12 East Parade LS1 2AJ Leeds West Yorkshire | 93785990001 |
CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 03 gen 2013 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 03 gen 2013 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 03 gen 2013 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sums standing to the credit of an account whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt owing by the bank represented by that sum see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0