CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED

CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06067297
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Prince Albert House
    2 Kingsmill Terrace
    NW8 6BN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCREENPRINT DONCASTER HOLDINGS LIMITED28 mar 200728 mar 2007
    L&P 174 LIMITED25 gen 200725 gen 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al21 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2014

    Stato del capitale al 07 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Gray's Inn Secretaries Limited il 09 gen 2013

    1 pagineCH04

    Bilancio consolidato redatto al 21 dic 2012

    25 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2012 al 21 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed screenprint doncaster holdings LIMITED\certificate issued on 29/01/13
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 dic 2012

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 dic 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mohamed Dirhem Abdo Saeed il 10 gen 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Gray's Inn Secretaries Limited come segretario in data 09 gen 2013

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sandra Margetts come segretario in data 21 dic 2012

    1 pagineTM02

    legacy

    pagineMG01

    Indirizzo della sede legale modificato da Quadrant 4 Yorkshire Way Armthorpe Doncaster South Yorkshire DN3 3FB in data 07 gen 2013

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Sandra Margetts come amministratore in data 21 dic 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Anthony Walton come amministratore in data 21 dic 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roderick Charles Ainslie come amministratore in data 21 dic 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy Richard Bradburn come amministratore in data 21 dic 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mohamed Dirhem Abdo Saeed come amministratore in data 21 dic 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    legacy

    16 pagineMG01

    legacy

    11 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    -
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    Segretario
    -
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00961412
    174868400001
    AINSLIE, Roderick Charles
    Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Glen Holme
    Perthshire
    Scotland
    Amministratore
    Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Glen Holme
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritishManaging Director43273080002
    BRADBURN, Timothy Richard
    Main Street
    Whittington
    WS14 9JU Lichfield
    1
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Main Street
    Whittington
    WS14 9JU Lichfield
    1
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishAccountant105361400001
    SAEED, Mohamed Dirhem Abdo
    Prince Albert House
    2 Kingsmill Terrace
    NW8 6BN London
    Longulf Trading (Uk) Ltd
    England
    Amministratore
    Prince Albert House
    2 Kingsmill Terrace
    NW8 6BN London
    Longulf Trading (Uk) Ltd
    England
    EnglandBritishDeputy Managing Director174741350002
    WALTON, Richard Anthony
    Meadows Road
    Manvers
    S63 5DJ Rotherham
    Brookfields Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Meadows Road
    Manvers
    S63 5DJ Rotherham
    Brookfields Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishOperations Director174741180001
    MARGETTS, Sandra
    2 Kingsmill Terrace
    NW8 6BN London
    Prince Albert House
    England
    Segretario
    2 Kingsmill Terrace
    NW8 6BN London
    Prince Albert House
    England
    BritishDirector94395470001
    LEE & PRIESTLEY SECRETARY LIMITED
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    90359580001
    BRINDLE, Robert Alan
    2 Valley Avenue
    South Elmsall
    WF9 2DE Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Valley Avenue
    South Elmsall
    WF9 2DE Pontefract
    West Yorkshire
    BritishDirector116733780001
    MARGETTS, Sandra
    Yorkshire Way
    Armthorpe
    DN3 3FB Doncaster
    Quadrant 4
    South Yorkshire
    Amministratore
    Yorkshire Way
    Armthorpe
    DN3 3FB Doncaster
    Quadrant 4
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector94395470001
    LEE & PRIESTLEY LIMITED
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    93785990001

    CEPAC DONCASTER HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 dic 2012
    Consegnato il 03 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    All assets debenture
    Creato il 21 dic 2012
    Consegnato il 03 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 21 dic 2012
    Consegnato il 03 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of an account whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0