TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED

TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06120444
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Ls Director Limited come amministratore in data 22 set 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Land Securities Management Services Limited come amministratore in data 22 set 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Louise Miller come amministratore in data 01 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Elizabeth Miles come amministratore in data 01 gen 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Arnaouti come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Louise Miller come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Arnaouti il 16 gen 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ls Director Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Land Securities Management Services Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Ls Company Secretaries Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 10 gen 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Marshall Gill come amministratore in data 14 lug 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 01 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2016

    Stato del capitale al 27 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Segretario
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4365193
    159674790001
    MILES, Elizabeth
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor235498150001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Segretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    British32603370002
    ARNAOUTI, Michael
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary539040004
    BYWATER, John Andrew
    6 Brunswick Drive
    HG1 2PZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    6 Brunswick Drive
    HG1 2PZ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor71820020004
    CADDICK, John Paul
    Flat 1 Imperial Mansions
    11 Royal Parade
    HG1 2TA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Flat 1 Imperial Mansions
    11 Royal Parade
    HG1 2TA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director118329820001
    CADDICK, Paul
    Deer Park Grange
    Monk Fryston South Milford
    LS25 5ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Deer Park Grange
    Monk Fryston South Milford
    LS25 5ER Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector2288420001
    CADDICK, Paul
    Deer Park Grange
    Monk Fryston South Milford
    LS25 5ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Deer Park Grange
    Monk Fryston South Milford
    LS25 5ER Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director2288420001
    GILL, Christopher Marshall
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133825020001
    HAMPSON, Lester Paul
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishDevelopment Director110887160001
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director32603370002
    JENNINGS, Gerald Robert
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director60061140001
    MILLER, Louise
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary199935770001
    WEATHERHEAD, Richard
    Aketon Close
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1AZ Harrogate
    Amministratore
    Aketon Close
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1AZ Harrogate
    EnglandBritishCompany Director37336810004
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4156575
    74974580001
    LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3934750
    173286110001
    LS DIRECTOR LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04299372
    133814600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6316299
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 02 mag 2008
    Consegnato il 08 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property situate at trinity quarter leeds t/nos WYK633497 and WYK876905 for details of further property charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2008
    Consegnato il 14 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties known as the trinity shopping centre, leeds comprising all that land under t/nos WYK118493, WYK118495 and WYK633497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties k/a land at the back of 36/38 albion street and land adjoining 28 commercial street leeds t/nos WYK118493 dn WYK118495. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of rental income
    Creato il 17 apr 2007
    Consegnato il 20 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rental income relating to f/h and l/h trinity street arcade burton arcade 33-44 briggate , 66,67,68,69,71 and 72 boar lane, land at the back of 36/38 albion street and land adj 28 commercial street leeds t/nos WYK633497, WYK118493 and WYK118495.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2007
    Consegnato il 20 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H trinity street arcade burton arcade 33-44 briggate and 66,67,68,69,71 and 72 boar lane leeds t/n WYK633497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 apr 2007
    Consegnato il 20 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0