TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 06120444 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 100 Victoria Street SW1E 5JL London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ls Director Limited come amministratore in data 22 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Land Securities Management Services Limited come amministratore in data 22 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2019 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Miller come amministratore in data 01 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Elizabeth Miles come amministratore in data 01 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Arnaouti come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Louise Miller come amministratore in data 01 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Arnaouti il 16 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ls Director Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Land Securities Management Services Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ls Company Secretaries Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 10 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Marshall Gill come amministratore in data 14 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 01 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
MILES, Elizabeth | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 235498150001 | ||||||||
DUDGEON, Peter Maxwell | Segretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
HIRST, Peter Graham | Segretario | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | British | 32603370002 | ||||||||||
ARNAOUTI, Michael | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 539040004 | ||||||||
BYWATER, John Andrew | Amministratore | 6 Brunswick Drive HG1 2PZ Harrogate North Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 71820020004 | ||||||||
CADDICK, John Paul | Amministratore | Flat 1 Imperial Mansions 11 Royal Parade HG1 2TA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 118329820001 | ||||||||
CADDICK, Paul | Amministratore | Deer Park Grange Monk Fryston South Milford LS25 5ER Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 2288420001 | ||||||||
CADDICK, Paul | Amministratore | Deer Park Grange Monk Fryston South Milford LS25 5ER Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 2288420001 | ||||||||
GILL, Christopher Marshall | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 133825020001 | ||||||||
HAMPSON, Lester Paul | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | Development Director | 110887160001 | ||||||||
HIRST, Peter Graham | Amministratore | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 32603370002 | ||||||||
JENNINGS, Gerald Robert | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | England | British | Company Director | 60061140001 | ||||||||
MILLER, Louise | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 199935770001 | ||||||||
WEATHERHEAD, Richard | Amministratore | Aketon Close Haggs Road Follifoot HG3 1AZ Harrogate | England | British | Company Director | 37336810004 | ||||||||
LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom |
| 173286110001 | ||||||||||
LS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Trinity Limited | 06 apr 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TRINITY QUARTER DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creato il 02 mag 2008 Consegnato il 08 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property situate at trinity quarter leeds t/nos WYK633497 and WYK876905 for details of further property charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 09 feb 2008 Consegnato il 14 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H properties known as the trinity shopping centre, leeds comprising all that land under t/nos WYK118493, WYK118495 and WYK633497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 29 ott 2007 Consegnato il 01 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H properties k/a land at the back of 36/38 albion street and land adjoining 28 commercial street leeds t/nos WYK118493 dn WYK118495. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 17 apr 2007 Consegnato il 20 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Rental income relating to f/h and l/h trinity street arcade burton arcade 33-44 briggate , 66,67,68,69,71 and 72 boar lane, land at the back of 36/38 albion street and land adj 28 commercial street leeds t/nos WYK633497, WYK118493 and WYK118495. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 2007 Consegnato il 20 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H trinity street arcade burton arcade 33-44 briggate and 66,67,68,69,71 and 72 boar lane leeds t/n WYK633497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 apr 2007 Consegnato il 20 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0