LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06137133 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PTCS 6155A LIMITED | 05 mar 2007 | 05 mar 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Morton Fraser Llp St Martins House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 08 gen 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David Mel Zuydam come amministratore in data 01 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Mel Zuydam come amministratore in data 11 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Katerina Brown come amministratore in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Scott Leitch Mackenzie come amministratore in data 30 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew William Lee come amministratore in data 05 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Alan Walters come amministratore in data 05 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 13 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 14 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mark Alan Walters come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mark Alan Walters come amministratore in data 14 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Nagle come amministratore in data 14 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew William Lee come amministratore in data 14 dic 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Huw Griffiths come amministratore in data 14 dic 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Segretario | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Amministratore | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Segretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246720001 | |||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Segretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566850001 | |||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Segretario | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Segretario | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| LONG, Jacqueline | Segretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213410001 | |||||||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Segretario | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 148856600001 | |||||||||
| BROWN, Katerina | Amministratore | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||
| BUXTON, Tony Martyn | Amministratore | Oaklands Somerford Road GL7 1FA Cirencester 33 Glos United Kingdom | England | British | 132588550002 | |||||||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Amministratore | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 154908310001 | |||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||||||
| HEWSON, John Francis | Amministratore | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Amministratore | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Amministratore | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| HULLEY, Stephen Paul | Amministratore | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 58163070002 | ||||||||||
| LEE, Andrew William | Amministratore | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Amministratore | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Amministratore | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||
| NAGLE, Michael | Amministratore | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Amministratore | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||
| QUINLAN, Rory John | Amministratore | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||||||
| ROUND, Richard Calvin | Amministratore | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||||||
| WALTERS, Mark Alan | Amministratore | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 317548840001 | |||||||||
| ZUYDAM, David Mel | Amministratore | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 259635370001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinis Wind Holdings Limited | 06 apr 2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 15 dic 2017 Consegnato il 29 dic 2017 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 09 ott 2013 Consegnato il 11 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 nov 2007 Consegnato il 26 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0