VENICE OWL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVENICE OWL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06137905
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VENICE OWL LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VENICE OWL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VENICE OWL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRIMROSEMARSH LIMITED05 mar 200705 mar 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di VENICE OWL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VENICE OWL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VENICE OWL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr James Alexander Burrell come amministratore in data 10 nov 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 061379050005, creata il 12 giu 2014

    91 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mar 2014

    Stato del capitale al 05 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mrs Geraldine Josephine Gallagher come amministratore in data 31 gen 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come amministratore in data 31 gen 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come segretario in data 31 gen 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    21 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    18 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    15 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    20 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy Doubleday come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di VENICE OWL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161879750001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156119110001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Segretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    BURRELL, James
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    Amministratore
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    British115775330001
    CLARKE, Martin Andrew, Dr
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    Amministratore
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    United KingdomBritish121053560001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    FLANAGAN, Sally Deborah
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish116577710001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Amministratore
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish147682410001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Amministratore
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish162620820001

    VENICE OWL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2014
    Consegnato il 18 giu 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    English law deed of accession
    Creato il 27 feb 2013
    Consegnato il 01 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2011
    Consegnato il 10 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 mag 2007
    Consegnato il 30 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 16 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0